GREETINGS FOR EATING LTD

GREETINGS FOR EATING LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREETINGS FOR EATING LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01770733
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREETINGS FOR EATING LTD?

    • (1584) /

    ¿Dónde se encuentra GREETINGS FOR EATING LTD?

    Dirección de la sede social
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREETINGS FOR EATING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WELLSPRINGS CONFECTIONERY LIMITED05 abr 199305 abr 1993
    WELLSPRINGS ENTERPRISES LIMITED 17 oct 198817 oct 1988
    BETHCAR LIMITED02 oct 198602 oct 1986
    BETHCAR AGRICULTURE LIMITED17 nov 198317 nov 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREETINGS FOR EATING LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2006

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREETINGS FOR EATING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 nov 2010

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 may 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 may 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de la propuesta del administrador

    66 páginas2.17B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    26 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador

    23 páginas2.24B

    Resultado de la reunión de acreedores

    68 páginas2.23B

    Declaración de asuntos

    31 páginas2.16B

    legacy

    1 páginas287

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2006

    12 páginasAA

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2005

    11 páginasAA

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas123

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11

    ¿Quiénes son los directivos de GREETINGS FOR EATING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Secretario
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British60088530001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Stephen David, Dr
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British54545850002
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish60088530001
    JOHN, Josh Verghese
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    Secretario
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    British51340860001
    PRICE, Gregory Philip
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    Secretario
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    British15769230004
    BOWER, Stuart Richard Hugo
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    Director
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    British73425870001
    BUTTERFIELD, Marcel
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    Director
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    United KingdomBritish61153960003
    COMMUNITY OF THE TRUE VINE LTD, The Directors
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British15769240001
    FORD, Glen
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    Director
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    British103152550001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Marina Helen
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British9654780004

    ¿Tiene GREETINGS FOR EATING LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 30 nov 2005
    Entregado el 02 dic 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The equipment being marden edwards overwrapper s/n 7424, loma combi metal detector s/n ACB43046-38591F and rondo compas icing roller s/n C4A421102 for details of further chattels charged please refer to form 395, fixed charge on all policies of insurance and all rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 02 dic 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 08 dic 2004
    Entregado el 11 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 05 mar 2003
    Entregado el 15 mar 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 15 mar 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 03 jul 2000
    Entregado el 04 jul 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies and all other liabilities due or to become due from the company to the chargee and all costs and expenses incurred in relation to the charge on a full indemnity basis together with interest thereon
    Breve descripción
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance Limited (The Charge Holder)
    Transacciones
    • 04 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 mar 1998
    Entregado el 27 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 ene 1998
    Entregado el 15 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £17,378 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Qualitec food depositor with pump action. All stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection, ebat crypto peerless food mixer and accessories, frigoscandia giro spiral cake drying tunnel, qualitech deposit.
    Personas con derecho
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transacciones
    • 15 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 ene 1998
    Entregado el 15 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £17,378 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all the plant machinery vehicles stock and shares and all other similar property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital fixtures and fittings.
    Personas con derecho
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transacciones
    • 15 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 feb 1996
    Entregado el 07 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £5,000 under the terms of the charge
    Breve descripción
    Qualitec food depositor with pump action all stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection (3 phase) eb 80 crypto peerless food mixer and accessories.
    Personas con derecho
    • North Nottinghamshire Training and Enterprise Council Limited
    Transacciones
    • 07 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GREETINGS FOR EATING LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 may 2008Fin de la administración
    04 jun 2007Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Profesional
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Daniel Plant
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    Profesional
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    2
    FechaTipo
    15 feb 2011Fecha de disolución
    30 may 2008Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Daniel Plant
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    Profesional
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Profesional
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0