EMBASSY INVESTMENTS LIMITED

EMBASSY INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEMBASSY INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01779219
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Handover Centre Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GRESWOLDE DEVELOPMENTS LIMITED19 dic 198319 dic 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Memorándum y Estatutos

    22 páginasMA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como director el 07 jun 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como secretario el 07 jun 2021

    1 páginasTM02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 08 jun 2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Power to issue shares, conflicts of interest, reduction amount credited to distributable reserves 27/05/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    8 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slouth SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL el 22 oct 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Stephen David Bender como director el 30 may 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VARLEY, Alexandria
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Director
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishAccountant114926980004
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretario
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British106610560001
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Secretario
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    British22634560001
    WOODSIDE SECRETARIES LIMITED
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Secretario corporativo
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    8879140001
    BENDER, Stephen David
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    Director
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant80314720001
    BRIDGES, Stuart John
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    Director
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCorporate Financier42176090002
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritishCompany Director116430680001
    HOLBECHE, Roger Malcolm
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    Director
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director16353130007
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Director
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishDirector83713020001
    NUTTALL, Peter Donald
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant29476820001
    PASCAN, Paul Michael
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAccountant52572380001
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Director
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant106610560001
    RUSSELL, Barry Charles
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    Director
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    BritishProperty Manager38094780002
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Director
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishCompany Secretary22634560001
    TICEHURST, Jonathon Mark
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    Director
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    BritishProperty Manger87622850001
    TORLAGE, Kevin Edgar
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Director
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    United KingdomSouth AfricanAccountant88938440001
    WILLIAMS, Paul David
    26 Wightwick Hall Road
    Wightwick
    WV6 8BZ Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    26 Wightwick Hall Road
    Wightwick
    WV6 8BZ Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director21594450001
    WINDER, Simon Paul
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    Director
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    BritishAccountant75937140001
    WINDUSS, David Alexander
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    Director
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    EnglandBritishAccountant64556700001
    YERBURY, John William Richard
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    Director
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    BritishDirector50339880001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Jacobs Investments Limited
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    01 jul 2016
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Companies Act
    Lugar de registroRegistrar Of Companies Cardiff
    Número de registro03871047
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene EMBASSY INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 13 mar 1997
    Entregado el 20 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 20 dic 1996
    Entregado el 24 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from jacobs holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the north west and east sides of thorncliffe lane chapeltown south yorkshire (freehold) with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of further charge
    Creado el 11 sept 1992
    Entregado el 16 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and /or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined
    Breve descripción
    Freehold property known as 3 and 4 bridge street nuneaton warwickshire.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 16 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 mar 1992
    Entregado el 08 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1991
    Entregado el 03 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £ 50,000
    Breve descripción
    130/133 station rd. Knowle solihull westmidlands t/n wm 281885.
    Personas con derecho
    • Ideal Estates Limited
    Transacciones
    • 03 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of further charge and variation
    Creado el 11 abr 1991
    Entregado el 15 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold 3 and 4 bridge street, nuneaton warwickshire title no wk 269051 all profit rents of the property.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1991Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 10 ago 1989
    Entregado el 11 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 3/4 bridge street nuneaton warwickshire t/no. Wk 269051. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 11 ago 1989Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 15 jun 1989
    Entregado el 16 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £270,000
    Breve descripción
    F/H property being shop units number 1 to 4 at market street kingswinford west midlands t/no wm 314371.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 16 jun 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 may 1989
    Entregado el 30 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises 130/132 station road knowle solihull west midlands with all buildings and fixtures by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 1989Registro de una carga
    • 25 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 20 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 61 & 62 high street dudley west midlands t/no wm 413927 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 20 may 1989Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 20 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property being land & buildings on the west side of spon lane west bromwich west midlands t/no wm 2188005 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 20 may 1989Registro de una carga
    Charge
    Creado el 26 oct 1987
    Entregado el 29 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 1987Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0