EMBASSY INVESTMENTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | EMBASSY INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01779219 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Dirección de la sede social | The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GRESWOLDE DEVELOPMENTS LIMITED | 19 dic 1983 | 19 dic 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 22 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como director el 07 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como secretario el 07 jun 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||
Estado de capital el 08 jun 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slouth SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL el 22 oct 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen David Bender como director el 30 may 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARLEY, Alexandria | Director | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | Accountant | 114926980004 | ||||
PRIEST, Malcolm John | Secretario | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 106610560001 | ||||||
SCOTT, Paul Clement | Secretario | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | British | 22634560001 | ||||||
WOODSIDE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 61 Woodside Road KT3 3AW New Malden Surrey | 8879140001 | |||||||
BENDER, Stephen David | Director | 56 Casewick Lane Uffington PE9 4SX Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Accountant | 80314720001 | ||||
BRIDGES, Stuart John | Director | Jasmine Cottage Nuptown RG42 6HS Warfield Berkshire | United Kingdom | British | Corporate Financier | 42176090002 | ||||
CLEVELEY, Michael Richard | Director | 75 Tiddington Road CV37 7AF Stratford Upon Avon Warwickshire | Great Britain | British | Company Director | 116430680001 | ||||
HOLBECHE, Roger Malcolm | Director | Barnmoor House Kington Lane CV35 8PP Claverdon Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 16353130007 | ||||
KINGSHOTT, Michael James | Director | Church Farm House Brick Kiln Lane TN12 8EN Horsmonden Kent | United Kingdom | British | Director | 83713020001 | ||||
NUTTALL, Peter Donald | Director | 41 Nags Head Avening GL8 8NZ Tetbury Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 29476820001 | |||||
PASCAN, Paul Michael | Director | 38 Hillcroft LU6 1TU Dunstable Bedfordshire | British | Accountant | 52572380001 | |||||
PRIEST, Malcolm John | Director | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 106610560001 | ||||
RUSSELL, Barry Charles | Director | 21 The Albany 67 Woodcote Road SM6 0PS Wallington Surrey | British | Property Manager | 38094780002 | |||||
SCOTT, Paul Clement | Director | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | Company Secretary | 22634560001 | ||||
TICEHURST, Jonathon Mark | Director | The Old House 64 High Street SN14 8LP Marshfield Wiltshire | British | Property Manger | 87622850001 | |||||
TORLAGE, Kevin Edgar | Director | 130 Westway Raynes Park SW20 9LS London | United Kingdom | South African | Accountant | 88938440001 | ||||
WILLIAMS, Paul David | Director | 26 Wightwick Hall Road Wightwick WV6 8BZ Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 21594450001 | ||||
WINDER, Simon Paul | Director | Flat 2 9 Westbury Road N12 7NY London | British | Accountant | 75937140001 | |||||
WINDUSS, David Alexander | Director | Glebe House Buckland Dinham BA11 2QW Frome Somerset | England | British | Accountant | 64556700001 | ||||
YERBURY, John William Richard | Director | 10 Bannerdown Close Batheaston BA1 7NJ Bath | British | Director | 50339880001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacobs Investments Limited | 01 jul 2016 | Waterside Drive Langley SL3 6AD Slough Unit 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene EMBASSY INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creado el 13 mar 1997 Entregado el 20 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 20 dic 1996 Entregado el 24 dic 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from jacobs holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings on the north west and east sides of thorncliffe lane chapeltown south yorkshire (freehold) with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of further charge | Creado el 11 sept 1992 Entregado el 16 sept 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and /or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined | |
Breve descripción Freehold property known as 3 and 4 bridge street nuneaton warwickshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 30 mar 1992 Entregado el 08 abr 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 dic 1991 Entregado el 03 dic 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £ 50,000 | |
Breve descripción 130/133 station rd. Knowle solihull westmidlands t/n wm 281885. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of further charge and variation | Creado el 11 abr 1991 Entregado el 15 abr 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold 3 and 4 bridge street, nuneaton warwickshire title no wk 269051 all profit rents of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 10 ago 1989 Entregado el 11 ago 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 3/4 bridge street nuneaton warwickshire t/no. Wk 269051. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge | Creado el 15 jun 1989 Entregado el 16 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £270,000 | |
Breve descripción F/H property being shop units number 1 to 4 at market street kingswinford west midlands t/no wm 314371. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 26 may 1989 Entregado el 30 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and premises 130/132 station road knowle solihull west midlands with all buildings and fixtures by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 20 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a 61 & 62 high street dudley west midlands t/no wm 413927 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 20 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property being land & buildings on the west side of spon lane west bromwich west midlands t/no wm 2188005 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 26 oct 1987 Entregado el 29 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0