KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED

KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01779361
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Planning & Academic Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GEMBANNER LIMITED20 dic 198320 dic 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ene 2016

    Estado de capital el 04 ene 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2015

    17 páginasAA

    Estado de capital el 30 abr 2015

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Eric Ronald Hassall como director el 22 abr 2015

    TM01

    Cese del nombramiento de David Cohen como director el 22 abr 2015

    TM01

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Benedict Burne Adams como director el 14 abr 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2015

    Estado de capital el 08 ene 2015

    • Capital: GBP 475,002
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2014

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Maria Nield como secretario el 28 oct 2013

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David James Carr Obe como director el 24 oct 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 ene 2014

    Estado de capital el 02 ene 2014

    • Capital: GBP 475,002
    SH01

    Nombramiento de Miss Laura Harrison como secretario

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2013

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Fiona Dumbelton como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Maria Nield como secretario

    1 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2012

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRISON, Laura
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    183935590001
    BUTTERS, Philip Carlton
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishUniversity Director30309160003
    CLIFFORD, Stephen Nigel
    Kalathos
    Cherry Tree Lane, Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    Secretario
    Kalathos
    Cherry Tree Lane, Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    BritishUniversity Administrator43505070002
    COHEN, David, Dr
    11 Springpool
    University Of Keele
    ST5 5BN Keele
    Staffordshire
    Secretario
    11 Springpool
    University Of Keele
    ST5 5BN Keele
    Staffordshire
    British3081610001
    DUMBELTON, Fiona
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    167967120001
    DUMBELTON, Fiona
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    Secretario
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    British135493970001
    DUMBELTON, Fiona
    Longton Road
    ST4 8ND Stoke-On-Trent
    45
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Longton Road
    ST4 8ND Stoke-On-Trent
    45
    Staffordshire
    United Kingdom
    British135493970001
    MONTANA-WILLIAMS, Kelly
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    Secretario
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    157852400001
    NIELD, Maria
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    177528990001
    YOUNGMAN, Edward Alexander
    Wellington Road
    Church Aston
    TF10 9EJ Newport
    East View
    Shropshire
    Secretario
    Wellington Road
    Church Aston
    TF10 9EJ Newport
    East View
    Shropshire
    British130579710001
    ADAMS, Benedict Burne
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCounty Councillor23101400002
    BODEN, Edward Michael, Councillor
    7 Meadowside Avenue
    Audley
    ST7 8EH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    7 Meadowside Avenue
    Audley
    ST7 8EH Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishTransport Officer174825720001
    BODEN, Philip Keeling
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    Director
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    BritishUniversity Director34859400001
    BRERETON, Michael Gerald
    The Middle House
    14 The Village Keele
    ST5 5AR Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    The Middle House
    14 The Village Keele
    ST5 5AR Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishLecturer102964310001
    CARR OBE, David James
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Administration
    Keele University Keele
    ST5 5BG Newcastle
    Planning & Academic
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Building Surveyor46345550001
    CLARKE, Karen Jane
    33 Princess Street
    ST5 1DD Newcastle
    Staffordshire
    Director
    33 Princess Street
    ST5 1DD Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant109513990001
    COHEN, David, Dr
    11 Springpool
    University Of Keele
    ST5 5BN Keele
    Staffordshire
    Director
    11 Springpool
    University Of Keele
    ST5 5BN Keele
    Staffordshire
    United KingdomBritishRetired3081610001
    COOPER, Geoffrey Clifford
    5 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    5 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant31526500001
    CRAWFORD, Patricia Mary
    Blaizefield Close
    Woore
    CW3 9SU Crewe
    25
    Cheshire
    Director
    Blaizefield Close
    Woore
    CW3 9SU Crewe
    25
    Cheshire
    United KingdomBritishUniversity Finance Director120452000003
    CROWE, Terence Frederick
    7 Trentway Close
    ST2 9JR Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    7 Trentway Close
    ST2 9JR Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishCounty Councillor53394460001
    DIX, Terence Alec
    27 Orchard Close
    B77 1NB Tamworth
    Staffordshire
    Director
    27 Orchard Close
    B77 1NB Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishCounty Councillor85249840001
    DUNN, Jon
    23 Junction Lane Burscough
    L40 5SN Ormskirk
    Lancashire
    Director
    23 Junction Lane Burscough
    L40 5SN Ormskirk
    Lancashire
    BritishChief Executive44997510001
    EDWARDS, John Henry
    2 Freebridge Close
    ST3 5XQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    2 Freebridge Close
    ST3 5XQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishRetired14871860001
    FENDER, Brian Edward Frederick, Sir
    Btg Plc 10 Fleet Place
    Limeburner Lane
    EC4M 7SB London
    Director
    Btg Plc 10 Fleet Place
    Limeburner Lane
    EC4M 7SB London
    United KingdomBritishUniversity Vice-Chancellor44857260001
    GIBSON, David Hall, Dr
    3 Cedarway
    Fulshaw Park
    SK9 1QJ Wilmslow
    Cheshire
    Director
    3 Cedarway
    Fulshaw Park
    SK9 1QJ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Engineer3081620001
    HASSALL, Eric Ronald
    32 Repton Drive
    ST5 3JF Newcastle
    Staffordshire
    Director
    32 Repton Drive
    ST5 3JF Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishRetired49915180002
    HOLDCROFT, David, Professor
    58 Thorn Lane
    LS8 1NF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    58 Thorn Lane
    LS8 1NF Leeds
    West Yorkshire
    BritishRetired32847980001
    LAWRENCE, Michael John
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    Director
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    United KingdomBritishCouncillor140675280001
    LAWRENCE, Michael John
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    Director
    University Secretarys Office
    The University Of Keele
    ST5 5BG Keele
    Staffshire
    United KingdomBritishCouncillor140675280001
    MAYOH, Keith Leslie
    8 Betley Hall Gardens
    Betley
    CW3 9BB Crewe
    Cheshire
    Director
    8 Betley Hall Gardens
    Betley
    CW3 9BB Crewe
    Cheshire
    BritishLocal Government Officer31526510001
    MOFFAT, James
    2 Springfield Crescent
    EH39 4NW North Berwick
    East Lothian
    Director
    2 Springfield Crescent
    EH39 4NW North Berwick
    East Lothian
    BritishHonorary Treasurer31526490001
    MORRIS, Simon John
    The Old Cottage Sandy Lane
    Baldwins Gate
    ST5 5DP Newcastle
    Staffordshire
    Director
    The Old Cottage Sandy Lane
    Baldwins Gate
    ST5 5DP Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishSecretary & Registrar57983430001
    OLEARY, John
    53 Heather Road
    Hednesford
    WS12 4EX Cannock
    Staffordshire
    Director
    53 Heather Road
    Hednesford
    WS12 4EX Cannock
    Staffordshire
    EnglandBritishCounty Councillor31526480001
    OSMAN, Philip Ernest
    Oulton Croft Nicholls Lane
    Oulton
    ST15 8UA Stone
    Staffordshire
    Director
    Oulton Croft Nicholls Lane
    Oulton
    ST15 8UA Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director2024290001
    RIGG, Paul Raymond
    The Croft
    10 School Lane Marchamley
    SY4 5LD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    The Croft
    10 School Lane Marchamley
    SY4 5LD Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishUniversity Director Of Finance36430960001

    ¿Tiene KEELE UNIVERSITY SCIENCE PARK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 10 oct 1994
    Entregado el 19 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land forming part of the campus the university of keele newcastle under lyme staffordshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 12 feb 1991
    Entregado el 22 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a plot of land on the campus of the university of keele keele staffordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 feb 1991Registro de una carga
    • 16 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 24 feb 1987
    Entregado el 10 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land & buildings at the university of keele, keele, staffordshire and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 1987Registro de una carga
    • 16 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0