INEOS STYRENICS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INEOS STYRENICS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01780289 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INEOS STYRENICS UK LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Interpath Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INEOS NOVA UK LIMITED | 01 oct 2007 | 01 oct 2007 |
| NOVA INNOVENE UK LIMITED | 19 oct 2005 | 19 oct 2005 |
| NOVA CHEMICALS EUROPE LIMITED | 22 feb 1999 | 22 feb 1999 |
| HUNTSMAN CHEMICAL COMPANY LIMITED | 22 dic 1983 | 22 dic 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 18 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Modification des détails de Mr James Arthur Ratcliffe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2022 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW3 3TY United Kingdom a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 18 jul 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Brown el 28 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Estado de capital el 26 may 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 may 2022
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ United Kingdom a Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW33TY el 28 feb 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony White como director el 03 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alex Hogan como director el 03 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John Wright Rey como secretario el 31 mar 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Paul Maddison como secretario el 31 mar 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Runcorn Site Hq South Parade P O Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE a Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ el 27 mar 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 7 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADDISON, Paul | Secretario | Heatherways Formby L37 7HL Liverpool 25 United Kingdom | 268585810001 | |||||||
| BROWN, Andrew, Mr. | Director | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | England | British | 192037840002 | |||||
| HOGAN, Alex | Director | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | United Kingdom | British | 250499700001 | |||||
| NICOLSON, John Allan | Director | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | England | British | 220697430001 | |||||
| DE LA CAMP, Christoph | Secretario | 26 Wasserwerksweg 40489 Dusseldorf 40489 Germany | German | 108467120001 | ||||||
| DICKS, Karen Dawn | Secretario | Lynfield Knutsford Road SK9 7RX Alderley Edge Cheshire | British | 86053880001 | ||||||
| MELLING, Timothy James | Secretario | Parke House16 Millwood Close Withnell Fold PR6 8AR Chorley Lancashire | British | 92709580001 | ||||||
| MULHALL, John Stephen | Secretario | 33 Pencarrow Close West Didsbury M20 2PS Manchester | British | 98433420001 | ||||||
| NICHOLS, Paul Frederick | Secretario | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | 176713610001 | |||||||
| PIZZEY, Andrew James | Secretario | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | 168280820001 | |||||||
| REY, David John Wright | Secretario | Evenwood Close WA7 1LZ Runcorn Unit 14 United Kingdom | 191075260001 | |||||||
| RIMMER, Matthew | Secretario | 5 Route De La Chaniaz Blonay 1807 Switzerland | British | 163534170001 | ||||||
| BILLINGHAME, Albert Victor Charles | Director | 3 Hamilton Drive Sunningdale SL5 9PP Ascot Berkshire | British | 31591260001 | ||||||
| CLARKE, Adin Lyndon | Director | 21 Buckfast Road Ashton On Mersey M33 5QB Sale Cheshire | British | 31591270002 | ||||||
| CRAIG, Thomas Orr, Dr | Director | 21 Church Brow Mottram SK14 6JJ Hyde Cheshire | British | 7757020001 | ||||||
| DE LA CAMP, Christoph | Director | 26 Wasserwerksweg 40489 Dusseldorf 40489 Germany | German | 108467120001 | ||||||
| DICKS, Karen Dawn | Director | Lynfield Knutsford Road SK9 7RX Alderley Edge Cheshire | British | 86053880001 | ||||||
| DURHAM, Richard Paulson | Director | 4624 Mount Spting Court Salt Lake City Utah 84117 FOREIGN United States Of America | American | 38682620004 | ||||||
| FYFE, Ian Mclagan | Director | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire | United Kingdom | British | 111920880001 | |||||
| GERHARD, Franken | Director | Chapel Lane SO43 7FG Lyndhurst Hawkslease Hampshire United Kingdom | Switzerland | German | 163505670001 | |||||
| GRAHAM, Peter David | Director | 2 Coniston Close SK9 7WD Alderley Edge Cheshire | Canadian | 100987140001 | ||||||
| HOWARD, Raymond | Director | 8 Barnswood Close Grappenhall WA4 2YJ Warrington Cheshire | England | British | 1470930001 | |||||
| HUNTSMAN, Jon Meade | Director | 3049 Sherwood Circle Salt Lake City Utah 84108 Usa | Usa | American | 40885090001 | |||||
| HUNTSMAN, Peter Riley | Director | 1399 Devonshire Drive Salt Lake City Utah 84108 Usa | American | 65184190001 | ||||||
| INGRAM, Robert Michael | Director | CH-1006 Lausanne Avenue De Florimont 18 Switzerland | Switzerland | British | 176713600001 | |||||
| JONES, Colin Howard | Director | Swanwick Close Goostrey CW4 8NU Crewe 11 Cheshire United Kingdom | England | British | 137584530001 | |||||
| LUCAS, Wes William | Director | 615 East Drive Sewickley Pennsylvania 15143 Usa | American | 62734630001 | ||||||
| MAHER, Michael John | Director | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 110531730003 | |||||
| MELLING, Timothy James | Director | Parke House16 Millwood Close Withnell Fold PR6 8AR Chorley Lancashire | England | British | 92709580001 | |||||
| MULHALL, John Stephen | Director | 33 Pencarrow Close West Didsbury M20 2PS Manchester | British | 98433420001 | ||||||
| NELSON, Daniel Aaron | Director | Le Bioley 1610 Vuibroye Vavd Switzerland | American | 58848730002 | ||||||
| PIZZEY, Andrew James | Director | Chapel Lane SO43 7FG Lyndhurst Hawkslease Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 181040410001 | |||||
| POOLE, Albert Terence | Director | 1130 Premier Way Sw Calgary T2T 1L6 Calgary Alberta Canada | Canadian | 62734280003 | ||||||
| PUGH, Martin | Director | 7 Chemin Des Vignes Pully Vaud Canton 1009 Switzerland | Switzerland | British | 108467030001 | |||||
| RASBAND, Ronald A | Director | Five Shadow Wood Lane Sandy Utah 84092 Usa | American | 46214560001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INEOS STYRENICS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr James Arthur Ratcliffe | 06 abr 2016 | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Tiene INEOS STYRENICS UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental fixed & floating charge. | Creado el 08 ago 1990 Entregado el 14 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 6-12-88. | |
Breve descripción See form 395 ref M75L for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed & floating charge debenture | Creado el 06 dic 1988 Entregado el 09 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the agent & other banks defined in the trust deed) under the terms of the security documents (as delivered) | |
Breve descripción Land & buildings at carrington works manchester (for full details see form 395 ref: M96). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 jun 1984 Entregado el 06 ene 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene INEOS STYRENICS UK LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0