INEOS STYRENICS UK LIMITED

INEOS STYRENICS UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINEOS STYRENICS UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01780289
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Interpath Limited 10
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INEOS NOVA UK LIMITED01 oct 200701 oct 2007
    NOVA INNOVENE UK LIMITED19 oct 200519 oct 2005
    NOVA CHEMICALS EUROPE LIMITED22 feb 199922 feb 1999
    HUNTSMAN CHEMICAL COMPANY LIMITED22 dic 198322 dic 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginasLIQ13

    Modification des détails de Mr James Arthur Ratcliffe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2022

    2 páginasPSC04

    Domicilio social registrado cambiado de Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW3 3TY United Kingdom a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 18 jul 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 06 jul 2022

    LRESSP

    Cambio de datos del director Mr Andrew Brown el 28 feb 2022

    2 páginasCH01

    Estado de capital el 26 may 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 may 2022

    • Capital: GBP 18,553,904
    3 páginasSH01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ United Kingdom a Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW33TY el 28 feb 2022

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Anthony White como director el 03 jun 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alex Hogan como director el 03 jun 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Wright Rey como secretario el 31 mar 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Paul Maddison como secretario el 31 mar 2020

    2 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de Runcorn Site Hq South Parade P O Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE a Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ el 27 mar 2020

    1 páginasAD01

    Renuncia del auditor

    7 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MADDISON, Paul
    Heatherways
    Formby
    L37 7HL Liverpool
    25
    United Kingdom
    Secretario
    Heatherways
    Formby
    L37 7HL Liverpool
    25
    United Kingdom
    268585810001
    BROWN, Andrew, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    EnglandBritish192037840002
    HOGAN, Alex
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    United KingdomBritish250499700001
    NICOLSON, John Allan
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Director
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    EnglandBritish220697430001
    DE LA CAMP, Christoph
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    Secretario
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    German108467120001
    DICKS, Karen Dawn
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    Secretario
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    British86053880001
    MELLING, Timothy James
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Secretario
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    British92709580001
    MULHALL, John Stephen
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    Secretario
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    British98433420001
    NICHOLS, Paul Frederick
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    176713610001
    PIZZEY, Andrew James
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    168280820001
    REY, David John Wright
    Evenwood Close
    WA7 1LZ Runcorn
    Unit 14
    United Kingdom
    Secretario
    Evenwood Close
    WA7 1LZ Runcorn
    Unit 14
    United Kingdom
    191075260001
    RIMMER, Matthew
    5 Route De La Chaniaz
    Blonay
    1807
    Switzerland
    Secretario
    5 Route De La Chaniaz
    Blonay
    1807
    Switzerland
    British163534170001
    BILLINGHAME, Albert Victor Charles
    3 Hamilton Drive
    Sunningdale
    SL5 9PP Ascot
    Berkshire
    Director
    3 Hamilton Drive
    Sunningdale
    SL5 9PP Ascot
    Berkshire
    British31591260001
    CLARKE, Adin Lyndon
    21 Buckfast Road
    Ashton On Mersey
    M33 5QB Sale
    Cheshire
    Director
    21 Buckfast Road
    Ashton On Mersey
    M33 5QB Sale
    Cheshire
    British31591270002
    CRAIG, Thomas Orr, Dr
    21 Church Brow
    Mottram
    SK14 6JJ Hyde
    Cheshire
    Director
    21 Church Brow
    Mottram
    SK14 6JJ Hyde
    Cheshire
    British7757020001
    DE LA CAMP, Christoph
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    Director
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    German108467120001
    DICKS, Karen Dawn
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    British86053880001
    DURHAM, Richard Paulson
    4624 Mount Spting Court
    Salt Lake City Utah 84117
    FOREIGN United States Of America
    Director
    4624 Mount Spting Court
    Salt Lake City Utah 84117
    FOREIGN United States Of America
    American38682620004
    FYFE, Ian Mclagan
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    Director
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United KingdomBritish111920880001
    GERHARD, Franken
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    SwitzerlandGerman163505670001
    GRAHAM, Peter David
    2 Coniston Close
    SK9 7WD Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    2 Coniston Close
    SK9 7WD Alderley Edge
    Cheshire
    Canadian100987140001
    HOWARD, Raymond
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    Director
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish1470930001
    HUNTSMAN, Jon Meade
    3049 Sherwood Circle
    Salt Lake City
    Utah 84108
    Usa
    Director
    3049 Sherwood Circle
    Salt Lake City
    Utah 84108
    Usa
    UsaAmerican40885090001
    HUNTSMAN, Peter Riley
    1399 Devonshire Drive
    Salt Lake City
    Utah
    84108
    Usa
    Director
    1399 Devonshire Drive
    Salt Lake City
    Utah
    84108
    Usa
    American65184190001
    INGRAM, Robert Michael
    CH-1006 Lausanne
    Avenue De Florimont 18
    Switzerland
    Director
    CH-1006 Lausanne
    Avenue De Florimont 18
    Switzerland
    SwitzerlandBritish176713600001
    JONES, Colin Howard
    Swanwick Close
    Goostrey
    CW4 8NU Crewe
    11
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Swanwick Close
    Goostrey
    CW4 8NU Crewe
    11
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish137584530001
    LUCAS, Wes William
    615 East Drive
    Sewickley
    Pennsylvania 15143
    Usa
    Director
    615 East Drive
    Sewickley
    Pennsylvania 15143
    Usa
    American62734630001
    MAHER, Michael John
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110531730003
    MELLING, Timothy James
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Director
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish92709580001
    MULHALL, John Stephen
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    Director
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    British98433420001
    NELSON, Daniel Aaron
    Le Bioley
    1610 Vuibroye
    Vavd
    Switzerland
    Director
    Le Bioley
    1610 Vuibroye
    Vavd
    Switzerland
    American58848730002
    PIZZEY, Andrew James
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181040410001
    POOLE, Albert Terence
    1130 Premier Way Sw
    Calgary
    T2T 1L6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Director
    1130 Premier Way Sw
    Calgary
    T2T 1L6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Canadian62734280003
    PUGH, Martin
    7 Chemin Des Vignes
    Pully
    Vaud Canton 1009
    Switzerland
    Director
    7 Chemin Des Vignes
    Pully
    Vaud Canton 1009
    Switzerland
    SwitzerlandBritish108467030001
    RASBAND, Ronald A
    Five Shadow Wood Lane
    Sandy
    Utah 84092
    Usa
    Director
    Five Shadow Wood Lane
    Sandy
    Utah 84092
    Usa
    American46214560001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INEOS STYRENICS UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr James Arthur Ratcliffe
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    06 abr 2016
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene INEOS STYRENICS UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental fixed & floating charge.
    Creado el 08 ago 1990
    Entregado el 14 ago 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 6-12-88.
    Breve descripción
    See form 395 ref M75L for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company LTD(As Trustee)
    Transacciones
    • 14 ago 1990Registro de una carga
    • 28 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed & floating charge debenture
    Creado el 06 dic 1988
    Entregado el 09 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the agent & other banks defined in the trust deed) under the terms of the security documents (as delivered)
    Breve descripción
    Land & buildings at carrington works manchester (for full details see form 395 ref: M96). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limites
    Transacciones
    • 09 dic 1988Registro de una carga
    • 28 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 jun 1984
    Entregado el 06 ene 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank PLC.
    Transacciones
    • 06 ene 1984Registro de una carga

    ¿Tiene INEOS STYRENICS UK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 jul 2022Inicio de la liquidación
    30 ago 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0