PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01781933 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
- Financiación de pensiones (65300) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Dirección de la sede social | 80 Strand London WC2R 0RL |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MILLBANK PROPERTY FUND LIMITED | 31 ene 1992 | 31 ene 1992 |
| MILLBANK POOLED FUND LIMITED | 09 ene 1984 | 09 ene 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 20 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jeremy Patrick Stewart Crawford el 24 jun 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Modification des détails de Pearson Pension Trustee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Richard Michael Wooff Kearton el 01 nov 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr James Anthony Boyd Joll el 20 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Jeremy Patrick Stewart Crawford como director el 01 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Pearson Pension Trustee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Richard Michael Wooff Kearton como director el 13 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Daniel Marshall como director el 13 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cessation de Pearson Group Pension Trustee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAVEN, Stephen Andrew | Secretario | 80 Strand London WC2R 0RL | 197019250001 | |||||||
| COLLINS, Aubrey Mark | Director | Strand WC2R 0RL London 80 | England | British | 146892050001 | |||||
| CRAWFORD, Jeremy Patrick Stewart | Director | 80 Strand London WC2R 0RL | England | British | 184834380002 | |||||
| JOLL, James Anthony Boyd | Director | Strand WC2R 0RL London 80 | England | British | 9322990006 | |||||
| KEARTON, Richard Michael Wooff | Director | 80 Strand London WC2R 0RL | England | British | 161787800002 | |||||
| PLENDER, William John Turner | Director | Strand WC2R 0RL London 80 | England | British | 27417890002 | |||||
| GRAHAM, John Stuart | Secretario | 80 Strand London WC2R 0RL | British | 149013750001 | ||||||
| JENKINS, Pamela | Secretario | 49 Reading Road RG24 8LT Basingstoke Hampshire | Us Citizen | 115843700001 | ||||||
| JONES, Stephen Andrew | Secretario | 36 Dartnell Close KT14 6PQ West Byfleet Surrey | British | 69836210001 | ||||||
| LAWLESS, Anette Vendelbo | Secretario | 64 Vallance Road Muswell Hill N22 7UB London | Danish | 9273320002 | ||||||
| SCOTT, Annette | Secretario | Strand WC2R 0RL London 80 | British | 68946000001 | ||||||
| BLACKNELL, David | Director | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Director | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||
| CABRELLI, Peter Primo | Director | 17 Manor Way CR8 3BL Purley Surrey | British | 78041090001 | ||||||
| COHEN, Norma Elizabeth | Director | 65 Agincourt Road NW3 2PA London | United States | 52727800002 | ||||||
| COLLETT, Gerald Alfred Smith | Director | 15 Langham Dene CR8 5BX Kenley Surrey | British | 10364240001 | ||||||
| FLOYD, Padraig Seosamh | Director | 80 Strand London WC2R 0RL | England | Irish | 185333680001 | |||||
| GILL, Peter Richard | Director | 30 Sheen Common Drive TW10 5BN Richmond Surrey | United Kingdom | British | 35996320004 | |||||
| GORMAN, Michael Christopher | Director | Whinfield Hook Heath Road GU22 0QD Woking Surrey | British | 9322970001 | ||||||
| GRAHAM, John Stuart | Director | 10 Hatley Close Friern Barnet N11 3LN London | British | 72224100001 | ||||||
| HACKMAN, John William | Director | Strand WC2R 0RL London 80 | England | British | 34890320001 | |||||
| HALL, David James | Director | 33 Cheyne Avenue South Woodford E18 2DP London | British | 9806710001 | ||||||
| HUGHES, Stuart James | Director | Chartsfield Fulford Road Fulford ST11 9QT Stoke-On-Trent Staffordshire | England | British | 502360001 | |||||
| HUNTER, David Ian | Director | Leewood, Titwood Road Newton Mearns G77 6RP Glasgow | United Kingdom | British | 1151130002 | |||||
| JOHNSON, Sally Kate Miranda | Director | 80 Strand London WC2R 0RL | England | British | 227733480001 | |||||
| LITTLE, Judith | Director | 24 Kings Avenue N10 7PB London | British | 47457820001 | ||||||
| MARSHALL, James Daniel | Director | 80 Strand London WC2R 0RL | England | British | 159227410001 | |||||
| MILLER, Alan Charles | Director | Strand WC2R 0RL London 80 | England | British | 9806700005 | |||||
| PENN, Richard Albert | Director | 5 Queens Road Belmont SM2 6BZ Sutton Surrey | British | 27125000001 | ||||||
| ROBERTS, Maurice Anthony | Director | 9 Strathmore Park South BT15 5HJ Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | 4172750001 | |||||
| ROBINSON, John Edwin | Director | Tanglewood Stortford Road, Hatfield Heath CM22 7DL Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 10456640001 | |||||
| STRADWICK, Ann Mary | Director | 18 Court Close GU30 7EA Liphook Hampshire | British | 27125020001 | ||||||
| WILLIAMS, Nigel John | Director | Oaklands Foxley Lane Binfield RG12 5EE Bracknell Berkshire | British | 8013200001 | ||||||
| WORTHINGTON, Michael Henry | Director | South Lodge Darlaston Park ST15 0ND Stone Staffordshire | British | 502950001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PEARSON PENSION PROPERTY FUND LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Pension Trustee Limited | 31 ago 2017 | WC2R 0RL London 80 Strand England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Pearson Group Pension Trustee Limited | 06 abr 2016 | Strand WC2R 0RL London 80 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Pearson Pension Trustee Limited | 06 abr 2016 | WC2R 0RL London 80 Strand England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0