OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED

OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOMICRON LEASING FACILITIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01793512
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    • (6521) /

    ¿Dónde se encuentra OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Prospect House
    11-13 Lonsdale Gardens
    TN1 1NU Tunbridge Wells
    Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NATWEST LEASING FACILITIES LIMITED13 jul 199013 jul 1990
    LOMBARD LEASING FACILITIES LIMITED21 feb 198521 feb 1985
    FUSECLASS LIMITED21 feb 198421 feb 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Creaseys 12 Lonsdale Gardens Tunbridge Wells TN1 1PA el 10 oct 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 sept 2011

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 ene 2011

    Estado de capital el 25 ene 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2009

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2008

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2007

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2006

    5 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2005

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas225

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2004

    11 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    8 páginas363s

    legacy

    3 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAM, Richard Gibson
    Mill House
    Church Road Fingringhoe
    CO5 7BN Colchester
    Secretario
    Mill House
    Church Road Fingringhoe
    CO5 7BN Colchester
    BritishSolicitor96877900001
    ALLPORT, Steven Kenneth
    Flat 2 76 London Road
    TN1 1DY Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Flat 2 76 London Road
    TN1 1DY Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishFinancial Advisor65865920001
    DEALTRY, Giles Roderick
    Buckles
    Ticehurst Road
    TN19 7NA Burwash Common
    East Sussex
    Director
    Buckles
    Ticehurst Road
    TN19 7NA Burwash Common
    East Sussex
    United KingdomEnglishConsultant89762390001
    OSBORNE, David Hase
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishBanker7602680004
    RICHARDS, Christopher Murray
    3 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0PG London
    Director
    3 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0PG London
    EnglandBritishFinancial92831120001
    BARTLETT, Paul Eugene
    16 Oster Street
    AL3 5JL St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    16 Oster Street
    AL3 5JL St Albans
    Hertfordshire
    British54206450004
    BUTLIN, Rachel Elizabeth
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    Secretario
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    British5966810002
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Secretario
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    BAILEY, Richard James
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Director
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    BritishBanker37824840001
    BARTON-SMITH, Colim
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishBanker23187320002
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Director
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    BritishBanker62111350002
    BULL, Richard Piers Ashworth
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    BritishBank Executive34371520003
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Director
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Banker53756030002
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBank Executive96202910001
    DENT, Nicholas Michael
    4 Acacia Road
    TW18 1BY Staines
    Middlesex
    Director
    4 Acacia Road
    TW18 1BY Staines
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant43922780002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Director
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    HASTINGS, Christopher Alan
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    Director
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    United KingdomBritishBanker68475890001
    HENDERSON CLELAND, Hugh John
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    Director
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    BritishBanker57536880001
    HILLIARD, Adrian Richard
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    Director
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    BritishInvestment Banker49021840001
    HING, Allen Peter
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    Director
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    BritishBanker11403910001
    HING, Allen Peter
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    Director
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    BritishBanker11403910001
    HOUGH, Robert
    36 Brightside
    CM12 0LJ Billericay
    Essex
    Director
    36 Brightside
    CM12 0LJ Billericay
    Essex
    EnglandBritishAccountant78456770001
    KEIGHLEY, Peter Thomas
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Director
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishBanker43234170001
    MABERLY, Michael Alan
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    BritishBanker1288990001
    PASHLEY, Robert Lawrence
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    Director
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    BritishBank Executive34481270003
    PURDY, John Douglas
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant68943220001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Director
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant/Banker64898180001
    SMITH, Malcolm David
    3 Widbury
    Stonewall Park Road Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    3 Widbury
    Stonewall Park Road Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishBanker111129330001
    SMITH, Malcolm David
    3 Widbury
    Stonewall Park Road Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    3 Widbury
    Stonewall Park Road Langton Green
    TN3 0HW Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishBanker111129330001
    THOMPSON, Peter Gordon
    42 Spring Park Avenue
    CR0 5EG Shirley
    Surrey
    Director
    42 Spring Park Avenue
    CR0 5EG Shirley
    Surrey
    BritishBanker61570160001
    WALKER, Bruce
    Plums Acre
    Wykehurst Lane, Ewhurst
    GU6 7PF Cranleigh
    Surrey
    Director
    Plums Acre
    Wykehurst Lane, Ewhurst
    GU6 7PF Cranleigh
    Surrey
    BritishBanker68234410002
    WEBSTER, Patrick Bart
    91 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8QP Brentwood
    Essex
    Director
    91 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8QP Brentwood
    Essex
    BritishBanker57380670001

    ¿Tiene OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second priority aircraft mortgage
    Creado el 26 abr 1999
    Entregado el 05 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations and liabilities due or to become due from the company to the the chargee (as shortfall guarantor) under clause 7 of the residual obligations agreement
    Breve descripción
    All of its rights title and interest (present and future) in and to the aircraft which means the airframe s/no.265, The parts and technical records. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority aircraft mortgage
    Creado el 26 abr 1999
    Entregado el 28 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations due or to become due from the company to atlantic aviation limited under clause 13.03 of the head lease agreement (as defined) in respect of any or all amounts payable by the company to atlantic aviation limited by way of rebate of rental as modified by clause 7.5 of the residual obligations agreement and clause 7.3 of the residual obligations agreement and to the chargee under clause 7.3 of the residual obligations agreement and the mortgage
    Breve descripción
    The aircraft means the airframe of the airbus A330-200 aircraft bearing registration mark g-eoma and airframe msn 265 together with the engines parts and technical records. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau; As Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries(As Defined)
    Transacciones
    • 28 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority deposit charge
    Creado el 26 abr 1999
    Entregado el 28 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations due or to become due from the company to atlantic aviation limited under clause 13.03 of the head lease agreement (as defined) in respect of any or all amounts payable by the company to atlantic aviation limited by way of rebate of rental as modified by clause 7.5 of the residual obligations agreement and clause 7.3 of the residual obligations agreement and to the chargee under clause 7.3 of the residual obligations agreement and the mortgage
    Breve descripción
    The deposit account of the company opened with the bank numbered 71012397 and designated "natwest leasing facilities limited - atlantic (g-eoma) sales proceeds account". See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau; As Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries(As Defined)
    Transacciones
    • 28 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second priority aircraft mortgage
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 15 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations and liabilities due or to become due from the company to the the chargee (as shortfall guarantor) under clause 7 of the residual obligations agreement
    Breve descripción
    All of its rights title and interest (present and future) in and to the aircraft which means the airframe s/no.261, The parts and technical records. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority aircraft mortgage
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 14 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations due or to become due from the company to atlantic aviation limited under clause 13.03 of the head lease agreement (as defined) in respect of any or all amounts payable by the company to atlantic aviation limited by way of rebate of rental as modified by clause 7.5 of the residual obligations agreement and clause 7.3 of the residual obligations agreement and to the chargee under clause 7.3 of the residual obligations agreement and the mortgage
    Breve descripción
    The airframe of the airbus A330-200 aircraft bearing the registration mark g-sman and airframe manufacturer's serial number 261 and any airframe substituted therefor. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau; As Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiares (Asdefined)
    Transacciones
    • 14 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority deposit charge
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 14 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all obligations due or to become due from the company to atlantic aviation limited under clause 13.03 of the head lease agreement (as defined) in respect of any or all amounts payable by the company to atlantic aviation limited by way of rebate of rental as modified by clause 7.5 of the residual obligations agreement and clause 7.3 of the residual obligations agreement and to the chargee under clause 7.3 of the residual obligations agreement and the mortgage
    Breve descripción
    The deposit account of the company opened with the bank numbered 71012370 and designated "natwest leasing facilities limited - atlantic (g-sman) sales proceeds account". See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau; As Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries (Asdefined)
    Transacciones
    • 14 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of covenant
    Creado el 27 mar 1987
    Entregado el 07 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £28,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 28/6/85 and a first statutory mortgage of even date
    Breve descripción
    All the company's rights title interest and benefits in or under the ship (see form 395 for further details).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1987Registro de una carga
    • 17 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First statutory mortgage
    Creado el 27 mar 1987
    Entregado el 07 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a deed of covenant of even date
    Breve descripción
    64/64TH shares of and in M.V. "stena seawell" registered in the name of the company at the prot aberdeen under official no. 701184.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1987Registro de una carga
    • 17 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene OMICRON LEASING FACILITIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 sept 2011Inicio de la liquidación
    24 may 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Stephen Willis
    Prospect House 11-13 Lonsdale Gardens
    TN1 1NU Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Prospect House 11-13 Lonsdale Gardens
    TN1 1NU Tunbridge Wells
    Kent

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0