WICKES DEVELOPMENTS LIMITED

WICKES DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWICKES DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01795477
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEWAPOINT LIMITED28 feb 198428 feb 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 23 sept 2022

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 12 sept 2022

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Notification de Travis Perkins Financing Company No.3 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 sept 2022

    2 páginasPSC02

    Cessation de Wickes Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 sept 2022

    1 páginasPSC07

    Nombramiento de Tp Directors Ltd como director el 27 jun 2022

    2 páginasAP02

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 dic 2020

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2019

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2018

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Peter Carter como director el 01 may 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2017

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Anthony David Buffin como director el 11 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alan Richard Williams como director el 11 jul 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 18 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 dic 2015

    18 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Secretario corporativo
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8929285
    186000060001
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Director
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BAMFORD, Carmel
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    Director
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    British17771540001
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Director
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Jeremy
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish111434190001
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Director
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    EDWARDS, Fred
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British75885570002
    FRIEDMAN, Douglas Benjamin
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    Director
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    American15200060001
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    JONES, Paul Samuel
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    Director
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    British75187050001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Director
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Director
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    THACKER, Colin David
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    Director
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    United KingdomBritish39672600001
    THOMAS, Geoffrey John
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    Director
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    British42980950001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    06 sept 2022
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07180292
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Wickes Properties Limited
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 abr 2016
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro1406897
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WICKES DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A mezzanine debenture
    Creado el 28 jul 2003
    Entregado el 13 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transacciones
    • 13 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Senior security accession deed
    Creado el 29 ene 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Retained land at high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land/blds on south-east side of high rd,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Creado el 29 ene 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land t high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land and buildings on the south-east side of high road,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Creado el 16 ene 2001
    Entregado el 31 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V,London Branch
    Transacciones
    • 31 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 2000
    Entregado el 09 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 09 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed being supplemental to a debenture dated 26 september 2000 (as defined)
    Creado el 27 oct 2000
    Entregado el 06 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) in any manner whatsoever and in any currency or currencies
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.,London Branch,as Security Agent
    Transacciones
    • 06 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge supplemental to a guarantee and debenture dated 3RD july 1996, a guarantee and debenture dated 12TH december 1996 and a guarantee and debenture dated 7TH january 1997 issued by the company
    Creado el 21 ago 1997
    Entregado el 03 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Breve descripción
    F/H 1 to 4 railway cottages and land and buildings on the south east side of high road goodmayes ilford. T/n-NGL76432.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 07 ene 1997
    Entregado el 15 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Creado el 12 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 03 jul 1996
    Entregado el 10 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 07 sept 1993
    Entregado el 10 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deposit and interim payment (as the same are defined in an agreement for the sale and purchase of the property dated 7/9/93 "the contract") due from the company to the chargee under the terms of the said contract
    Breve descripción
    The l/h land at marsh barton road exeter more particularly describes in an agreement dated 7/9/93.
    Personas con derecho
    • Wgtc Nominees Limited
    Transacciones
    • 10 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 feb 1993
    Entregado el 06 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,350,000 due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Breve descripción
    F/H land and buildings to the south of cuton hall alne springfield chelmsford currently forming part of t/n ex 469422.
    Personas con derecho
    • Wgtc Nominees Limited
    Transacciones
    • 06 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 24 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WICKES DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 sept 2022Inicio de la liquidación
    23 dic 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0