GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED

GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01805442
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 23 dic 2010

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 05 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 27 sept 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director John William Burton el 11 ago 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Rachel Jacobs como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Gareth Richard Wright como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mark Henry Kerswell el 02 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 02 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Adam Christopher Walker el 27 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Secretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Director
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    Director
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    EnglandBritish69164290002
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Secretario
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Secretario
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Secretario
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Secretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Secretario
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Secretario
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Director
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Director
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    RIDINGS, Stephen
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    Director
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    British45198530001
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Director
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Director
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    ¿Tiene GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 22 nov 1990
    Entregado el 11 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the charge)
    Breve descripción
    (See M182 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Companyof New York (As Agent)
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 11 dic 1990Registro de una carga
    • 06 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 feb 1990
    Entregado el 14 feb 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All bookdebts of the company present & future.
    Personas con derecho
    • Ulster Factors Limited
    Transacciones
    • 14 feb 1990Registro de una carga
    Letter of set off
    Creado el 27 sept 1985
    Entregado el 02 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1985Registro de una carga
    Letter of set off
    Creado el 26 oct 1984
    Entregado el 31 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Any sum on sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company, with lloyds bank PLC.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 31 oct 1984Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 05 jun 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    Breve descripción
    All assets with present and future including uncalled capital by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Grosvenor Press PLC
    Transacciones
    • 05 jun 1984Registro de una carga
    Trust deed
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 05 jun 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    Breve descripción
    All f/h and l/h property of the company and all buildings and structures erected thereon and all fixtures and fittings and effects.
    Personas con derecho
    • Albion Trust Limited
    Transacciones
    • 05 jun 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0