SBLI REALISATIONS LIMITED

SBLI REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSBLI REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01808759
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SBLI REALISATIONS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    9 Reans Meadow
    Great Cambourne
    CB23 5AB Cambridge
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SLUMBERLAND INTERNATIONAL LIMITED27 may 198827 may 1988
    SLUMBERLAND INVESTMENTS LIMITED25 ago 198725 ago 1987
    SLUMBERLAND INTERNATIONAL LIMITED13 abr 198413 abr 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de * 1 Windover Road Huntingdon Cambridgeshire PE29 7EF* el 14 ene 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 ago 2013

    Estado de capital el 01 ago 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed slumberland international LIMITED\certificate issued on 23/04/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name23 abr 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 abr 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 26 mar 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jons Hansson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Carl Pettersson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Franciscus Van De Ven como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gunnar Johansson como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Carl Anders Wilhelm Pettersson como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gordon Mitchell como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Roy Francis como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Gunnar Johansson como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SBLI REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FRANCIS, Paul Roy
    Reans Meadow
    Great Cambourne
    CB23 5AB Cambridge
    9
    England
    Director
    Reans Meadow
    Great Cambourne
    CB23 5AB Cambridge
    9
    England
    EnglandBritish163475790001
    BRAZIER, Frank Bernard
    31 St Judiths Lane
    Sawtry
    PE28 5XE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    31 St Judiths Lane
    Sawtry
    PE28 5XE Huntingdon
    Cambridgeshire
    British32088750001
    HUTCHESON, Julie Patricia
    1 New Barn Street
    Shaw
    OL2 7JE Oldham
    Lancashire
    Secretario
    1 New Barn Street
    Shaw
    OL2 7JE Oldham
    Lancashire
    British33882120001
    LUDDINGTON, Stephen John
    30 Ursula Street
    SW11 3DW London
    Secretario
    30 Ursula Street
    SW11 3DW London
    British93474940002
    MAYNARD, Tristan Basil Merlin
    4 Beaumonds Way
    Bamford
    OL11 5NL Rochdale
    Lancashire
    Secretario
    4 Beaumonds Way
    Bamford
    OL11 5NL Rochdale
    Lancashire
    British1180990001
    RHODES, David
    4 Buckingham Road
    Heaton Chapel
    SK4 4QU Stockport
    Cheshire
    Secretario
    4 Buckingham Road
    Heaton Chapel
    SK4 4QU Stockport
    Cheshire
    British28449100001
    ROONEY, Paul David
    3 Brookway
    Grasscroft
    OL4 4EU Oldham
    Secretario
    3 Brookway
    Grasscroft
    OL4 4EU Oldham
    British109340890001
    SOUTHWELL, Nicholas Thomas
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    Secretario
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    British239714960001
    SOUTHWELL, Nicholas Thomas
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    Secretario
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    British239714960001
    ADOLFSSON, Bengt Gunnar
    Bengt Langhs Gata 13
    S 254 33 Helsingborg
    Sweden
    Director
    Bengt Langhs Gata 13
    S 254 33 Helsingborg
    Sweden
    Swedish76897020001
    BILLERBECK, Klaus Peter
    Rittershausstr. 7
    D-65187 Wiesbaden
    Germany
    Director
    Rittershausstr. 7
    D-65187 Wiesbaden
    Germany
    German90371180002
    BUCKLEY, Peter
    The Coach House Hollyville
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7DR Oldham
    Lancashire
    Director
    The Coach House Hollyville
    Holmfirth Road Greenfield
    OL3 7DR Oldham
    Lancashire
    British72545880001
    CHRISTENSON, Jan Peter Ernest
    Sanekullavagen 8
    Malmoe
    Se 21774
    Sweden
    Director
    Sanekullavagen 8
    Malmoe
    Se 21774
    Sweden
    Swedish117237900002
    HANSSON, Jons Thomas Christer
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    SwedenSwedish146077730001
    JOHANSSON, Gunnar
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    England
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    England
    GermanyNorwegian160270650001
    LUDDINGTON, Stephen John
    30 Ursula Street
    SW11 3DW London
    Director
    30 Ursula Street
    SW11 3DW London
    EnglandBritish93474940002
    MAYNARD, Tristan Basil Merlin
    4 Beaumonds Way
    Bamford
    OL11 5NL Rochdale
    Lancashire
    Director
    4 Beaumonds Way
    Bamford
    OL11 5NL Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish1180990001
    MITCHELL, Gordon
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish43341530003
    NEWSTEAD, Patrick John Michael
    Newlands 257 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD7 2TX Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Newlands 257 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD7 2TX Huddersfield
    West Yorkshire
    British40921930001
    PALSSON, Anders Bertil
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    SwedenSwedish123741960001
    PETTERSSON, Carl Anders Wilhelm
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    SwedenSwedish166780230001
    ROONEY, Paul David
    3 Brookway
    Grasscroft
    OL4 4EU Oldham
    Director
    3 Brookway
    Grasscroft
    OL4 4EU Oldham
    EnglandBritish109340890001
    SCHIESS, Felix
    Bico Birchler & Co Ag
    FOREIGN Schanis/Sg Ch-8718
    Switzerland
    Director
    Bico Birchler & Co Ag
    FOREIGN Schanis/Sg Ch-8718
    Switzerland
    Swiss29753720001
    SOUTHWELL, Nicholas Thomas
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    Director
    2 Tabley Gardens
    SK6 7JY Marple
    Cheshire
    EnglandBritish239714960001
    UELTSCHI, Urs Adolph
    Schmitten/Fr
    Ch 3185
    FOREIGN Switzerland
    Director
    Schmitten/Fr
    Ch 3185
    FOREIGN Switzerland
    Swisssh48355770001
    VAN DE VEN, Franciscus Gerardus Maria
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    Director
    Windover Road
    PE29 7EF Huntingdon
    1
    Cambridgeshire
    NetherlandsDutch123199190001

    ¿Tiene SBLI REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite debenture
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 31 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the secured obligations due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 sept 2001
    Entregado el 12 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 abr 1993
    Entregado el 21 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 1/4/93
    Breve descripción
    Please see form 395 M80 and continuation sheets for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation
    Transacciones
    • 21 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0