SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01809366
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    • Fabricación de sidra y otros vinos de frutas (11030) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BASKMIST LIMITED17 abr 198417 abr 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 08 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg como director el 06 oct 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Malcolm Dunn como director el 06 oct 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Michael Forde como director el 06 oct 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anne Louise Oliver como director el 06 oct 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sean Michael Paterson como director el 08 oct 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anne Louise Oliver como secretario el 06 oct 2014

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mrs Anne Louise Oliver el 01 abr 2014

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mrs Kelly Taylor-Welsh el 01 abr 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Sean Michael Paterson el 01 abr 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Anne Louise Oliver el 01 abr 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mrs Kelly Taylor-Welsh el 01 ago 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de John Charles Low como director el 31 mar 2012

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Secretario
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Secretario
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Secretario
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Secretario
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    AITCHISON, Nicholas Martin Leslie
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    Director
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    British6195750001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Director
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritish132259650001
    BOND, Denis Joseph Christopher
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    Director
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    British26007550001
    BROWN, Colin Carlyle Campbell
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Director
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    British61755350001
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Director
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    DOOBAR, Mark Simon
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    Director
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    British34501450002
    EGGLETON, Jonathan Philip
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    Director
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    British83396140001
    FREER, Nigel
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    Director
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    British59149820001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Director
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    British32520640003
    GREGORY, Trevor John
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    Director
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    United KingdomBritish106240790001
    HARRINGTON, Robert Arthur
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    British9899150004
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Director
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish71528270003
    HODDER, Anthony Mark
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    Director
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    British60326120001
    HUGHES, Michael John
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    Director
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish101949350001
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Director
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrench83396080001
    KIRKHOPE, Ian
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    Director
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    British37450060001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Director
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish162758370001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Director
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish141021760002
    PAYNE, William John
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Director
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    ScotlandBritish136005370001
    PENNYCOOK, Richard John
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    Director
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    British87825540001
    RUDGARD, John Kennish
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    Director
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    British17349320001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Director
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Director
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    SYMONDS, Neville Richard
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    Director
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    United KingdomBritish9899170001
    TEDFORD, Craig
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Director
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish106867030001
    TEMPLEMAN, Miles Howard
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    Director
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish15411870001

    ¿Tiene SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 15 ene 2003
    Entregado el 22 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transacciones
    • 22 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 sept 1986
    Entregado el 08 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property at stoke comprising factory premises adjoining land the plough garage and public house. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Greenhall Whitley PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1986Registro de una carga
    • 25 ago 1988Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0