SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01809366 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
- Fabricación de sidra y otros vinos de frutas (11030) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BASKMIST LIMITED | 17 abr 1984 | 17 abr 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 08 dic 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg como director el 06 oct 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Malcolm Dunn como director el 06 oct 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Michael Forde como director el 06 oct 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anne Louise Oliver como director el 06 oct 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sean Michael Paterson como director el 08 oct 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anne Louise Oliver como secretario el 06 oct 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Anne Louise Oliver el 01 abr 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Kelly Taylor-Welsh el 01 abr 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sean Michael Paterson el 01 abr 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Anne Louise Oliver el 01 abr 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Kelly Taylor-Welsh el 01 ago 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Charles Low como director el 31 mar 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNN, Malcolm James Shiel | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | British | 191401290001 | |||||
| FORDE, David Michael | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Ireland | Irish | 178655370001 | |||||
| TAYLOR-WELSH, Kelly | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | 167915590003 | |||||
| VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | Dutch | 167853370002 | |||||
| AVES, Simon Howard | Secretario | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | British | 132259650001 | ||||||
| OLIVER, Anne Louise | Secretario | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | British | 132910690001 | ||||||
| STEBBINGS, William George | Secretario | Burghill HR4 7RX Hereford The Forge Herefordshire | British | 129413480001 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretario | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | 80951870003 | ||||||
| AITCHISON, Nicholas Martin Leslie | Director | Lower Barn Llancloudy HR2 8QR Hereford Herefordshire | British | 6195750001 | ||||||
| AVES, Simon Howard | Director | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | Scotland | British | 132259650001 | |||||
| BOND, Denis Joseph Christopher | Director | Cricket Cottage Churchfield Cradley Malvern Worcestershire | British | 26007550001 | ||||||
| BROWN, Colin Carlyle Campbell | Director | Little Bower 10 Nuns Walk GU25 4RT Virginia Water Surrey | British | 61755350001 | ||||||
| CRAWSHAY, William John Julian | Director | The Old Vicarage NE41 8AT Wylam Northumberland | United Kingdom | British | 79182280001 | |||||
| DOOBAR, Mark Simon | Director | 105 Canada Way Lower Wick WR2 4DG Worcester | British | 34501450002 | ||||||
| EGGLETON, Jonathan Philip | Director | Court Leet Church Road GL17 0LL Longhope Gloucestershire | British | 83396140001 | ||||||
| FREER, Nigel | Director | Stoneham House Maund Common Bodenham HR1 3JB Hereford Herefordshire | British | 59149820001 | ||||||
| FURSE, Timothy Machin | Director | Rock House Fownhope HR1 4NT Herefordshire | British | 32520640003 | ||||||
| GREGORY, Trevor John | Director | The Hollies HR2 8JE Llanwarne Herefordshire | United Kingdom | British | 106240790001 | |||||
| HARRINGTON, Robert Arthur | Director | The Field House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Gloucestershire | British | 9899150004 | ||||||
| HITCHINER, Christopher David | Director | Dunan House Clehonger HR2 9SF Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | 71528270003 | |||||
| HODDER, Anthony Mark | Director | New End Cottage Canon Pyon HR4 8NY Hereford | British | 60326120001 | ||||||
| HUGHES, Michael John | Director | 3 Ailsa Road TW1 1QJ Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 101949350001 | |||||
| JAMET, Jean Francois | Director | 3 Sion Hill Place BA1 5SJ Bath | England | French | 83396080001 | |||||
| KIRKHOPE, Ian | Director | Vineyard Hill House 34 Vineyard Road HR1 1TT Hereford | British | 37450060001 | ||||||
| LOW, John Charles | Director | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | United Kingdom | British | 162758370001 | |||||
| OLIVER, Anne Louise | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | 132910690001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Director | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | British | 141021760002 | |||||
| PAYNE, William John | Director | Ashby House 1 Bridge Street TW18 4TP Staines Middlesex | Scotland | British | 136005370001 | |||||
| PENNYCOOK, Richard John | Director | Sherington Place MK16 9PD Sherington Buckinghamshire | British | 87825540001 | ||||||
| RUDGARD, John Kennish | Director | Claremont Court Swainshill HR4 7PU Hereford Herefordshire | British | 17349320001 | ||||||
| STEBBINGS, William George | Director | Burghill HR4 7RX Hereford The Forge Herefordshire | British | 129413480001 | ||||||
| STEVENS, Mark | Director | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | 80951870003 | ||||||
| SYMONDS, Neville Richard | Director | Drakewell Stoke Lacy HR7 4HG Bromyard Herefordshire | United Kingdom | British | 9899170001 | |||||
| TEDFORD, Craig | Director | Ashby House 1 Bridge Street TW18 4TP Staines Middlesex | United Kingdom | British | 106867030001 | |||||
| TEMPLEMAN, Miles Howard | Director | Whitmore Farm Church Road GU20 6BH Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 15411870001 |
¿Tiene SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 15 ene 2003 Entregado el 22 ene 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 sept 1986 Entregado el 08 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £5,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property at stoke comprising factory premises adjoining land the plough garage and public house. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0