LEASECONTRACTS LIMITED

LEASECONTRACTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEASECONTRACTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01810100
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEASECONTRACTS LIMITED?

    • Venta de coches nuevos y vehículos de motor ligeros (45111) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra LEASECONTRACTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEASECONTRACTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JORDANS 160 PUBLIC LIMITED COMPANY18 abr 198418 abr 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEASECONTRACTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEASECONTRACTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2023

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2022

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2021

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2020

    9 páginasLIQ03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF el 17 oct 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 sept 2019

    LRESSP

    Nombramiento de Oakwood Corporate Secretary Limited como secretario el 23 jul 2019

    2 páginasAP04

    Notification de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019

    2 páginasPSC02

    Cessation de Ige Usa Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Norris Andrew Geldard el 04 feb 2019

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Ige Usa Investments en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Anthony William Greenway como director el 30 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Norris Andrew Geldard como director el 10 sept 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Stewart Girling como director el 10 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT el 17 ago 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Notification de Ige Usa Investments en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    ¿Quiénes son los directivos de LEASECONTRACTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7038430
    146358090001
    GELDARD, Norris Andrew
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish244576750001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    ABBOTT, Courtenay
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Secretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    172560620001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Secretario
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    British45103500001
    ESSEX, Alicia
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    Secretario
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    British55569560002
    FRENCH, Ann
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    161504050001
    JOHNSON, Paul Robert
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Secretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    British106143590001
    KERSHAW, Simon John
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    Secretario
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    British106236300001
    PATMORE, Ian Robert
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    Secretario
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    British64498630002
    PEERMOHAMED, Zahra
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Secretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    192967230001
    RYLATT, Diane
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    British46068950001
    TAYLOR, Timothy John
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42497260001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Secretario corporativo
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ANDERSON, Roger
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    Director
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    British60138290001
    BECQUE, Geoffrey Frederick
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    Director
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14428770001
    BURR, Jonathan Charles
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    Director
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish49902210001
    CHAPMAN, Mark Andrew
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    Director
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    British54283410002
    CHAPMAN, Mark Andrew
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    Director
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    British54283410001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Director
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish45103500001
    D'ADDA, Alessandro Pietro
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish47772540001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Director
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    DUFF, Paul Anthony
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    Director
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    British122035530001
    FARRAR, Daniel
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    Director
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British42497200001
    FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish139406230001
    FORD, Toby Duncan
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    Director
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    United KingdomBritish148654320001
    GREEN, Richard William
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    Director
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    British121346530001
    GREENWAY, Anthony William
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202871130001
    HUDDART, Steven John
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Director
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    EnglandEnglish191546760001
    JEANS, Roderick Manning
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    Director
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    British50601570001
    JENKINS, John Michael
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    Director
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    EnglandBritish115008010001
    KILLEEN, Gary Francis Paul
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    EnglandEnglish81330540001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    Director
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritish1483050001
    LOMAS, Paul John
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    Director
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish127596100001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LEASECONTRACTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    23 jul 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1500252
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3255766
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LEASECONTRACTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £404,822.57 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date 7/6/95 contract no 1030474 vehicle hire agreement model vauxhall brava 2.5I a/c no 34. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £45,553.63 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements :- date 2.6.95 contract no 1030728 vehicle hire agreement model ford transit 2.5 regn no M289 yhj a/c/no 22. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £160,099.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £349,787.92 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights title and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £87,116.29 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £13,933.14 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 02 ago 1995
    Entregado el 08 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £27,772.02 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First charge
    Creado el 28 jun 1995
    Entregado el 12 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12TH december 1994 and/or this charge
    Breve descripción
    The company assigns and charges to the bank by way of first fixed legal charge:- (I) all the benefits rights and title of the company in the contracts; and (ii) each and every motor vehicle from time to time subject of the contracts (the "motor vehicles"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 12 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creado el 26 jun 1995
    Entregado el 01 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Breve descripción
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements :- sub-hirer sony united kingdom limited ford mondeo 2OI glx h/back regn no M301 mpd. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Sovereign Finances PLC
    Transacciones
    • 01 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creado el 04 may 1995
    Entregado el 09 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Breve descripción
    All rights benefits and interest present and future in and to sub-hire agreements made between various sub-hirers. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Sovereign Finance PLC
    Transacciones
    • 09 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creado el 19 abr 1995
    Entregado el 26 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreemnts
    Breve descripción
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees :- customer no 021766 schedule no 000015 agreement no 01/308/01/513884 reg no M29 eea rover 214SE1 41 customer ref 1028472. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nws Bank PLC
    Transacciones
    • 26 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 23 mar 1995
    Entregado el 08 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £222,479.54 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights title and interest of the company in the attached schedule contract no 1027675 agreement vehicle contract purchase reg no M217 odp make rover 2.0I. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 08 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 23 mar 1995
    Entregado el 29 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £221,528.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All the rights title and interest of the company in and under the agreements ,as specified in the schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements,all monies from time to time payable under any insurance payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 23 mar 1995
    Entregado el 29 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £75,555.25 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under or pursuant to the terms of the agreement
    Breve descripción
    All rights title and interest in and under the said agreements ,all monies now or hereafter to become payable under the agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all monies from time to time payable under the insurance in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 23 mar 1995
    Entregado el 29 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £229,169.13 together with all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Breve descripción
    Specific charge over all the rights and interests of the company under the agreements specified in the schedule, all monies now or hereafter to become payable under the said agreements , the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all insurances payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 29 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creado el 09 dic 1994
    Entregado el 22 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreements
    Breve descripción
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nws Bank PLC
    Transacciones
    • 22 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Master assignment
    Creado el 05 dic 1994
    Entregado el 22 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agrements
    Breve descripción
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedules attached to the form 395 entered into pursuant to the master assignment.
    Personas con derecho
    • Nws Bank PLC
    Transacciones
    • 22 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £359,353.33 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-22.9.94, Contract no.-1025575, Type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-48, reg no-M113 xow, make/model-honda civic. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £135,919.45 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-8.11.94, Contract no-1025865, type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-42, reg no-M108 njb, make/model-renault 19. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £36,467.67 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-25.10.94, Contract no.-1026204, Type of agreement-schedule to master agreement, period of agt-12, reg no.-M791 jpf, make/model-rover 200 1.4I. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £58,680.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-28.9.94, Contract no.-1026224, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-24, reg no.-L416 kto, make/model-vw passat. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £47,047.49 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-18.10.94, Contract no-1026870, type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-28, reg no.-L753JCF, make/model-vauxhall frontera. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 25 nov 1994
    Entregado el 02 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £270,688.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements date-9.11.94, Contract no.-1027231, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-36, reg no.-L688 sav, make/model-rover 600 2.01. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 02 dic 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Master assignment and certificte of assignment
    Creado el 03 nov 1994
    Entregado el 04 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement of even date
    Breve descripción
    All rights benefit and interest present and future in and 70 sub-hiring agreements :- ford granada 2.01 scorpio 4 dr saloon sin auto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Sovereign Finance PLC
    Transacciones
    • 04 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge agreement
    Creado el 13 jul 1994
    Entregado el 16 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £107,344.53 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement.
    Breve descripción
    All the rights and interests of the company under the agreements specified in the attached schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements. The vehicles comprised in and the subject of the said agreements as specified in the said schedule, and all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. The terms applicable to the charge agreement restrict the creation of any other charge whatsoever over the charged property.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 16 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LEASECONTRACTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 jun 2024Fecha prevista de disolución
    26 sept 2019Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0