FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01812127 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 25 Canada Square E14 5LQ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SUNGARD SHERWOOD SYSTEMS LIMITED | 15 jul 2004 | 15 jul 2004 |
| SUNGARD SHERWOOD SYSTEMS PLC | 31 oct 2003 | 31 oct 2003 |
| SHERWOOD INTERNATIONAL PLC | 07 may 1996 | 07 may 1996 |
| SHERWOOD COMPUTER SERVICES PLC | 18 mar 1985 | 18 mar 1985 |
| GALERULE LIMITED | 30 abr 1984 | 30 abr 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kathleen Teresa Thompson como director el 25 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa | 1 páginas | DS02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Charles Harrison Keller como director el 01 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marc Mayo como director el 30 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 15 mar 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 137 páginas | AA | ||||||||||
Cessation de Fis Insurance Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Fis Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Kathleen Teresa Thompson el 01 abr 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 204 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Fis Insurance Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jun 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Level 39 25 Canada Square London E14 5LQ a 25 Canada Square London E14 5LQ el 29 jun 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLIS, Howard | Secretario | Level 39 Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ London Fis Legal Department United Kingdom | British | 80930830001 | ||||||
| KELLER, Charles Harrison | Director | c/o Fis Legal Department Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 40, 25 England | United States | American | 283440470001 | |||||
| ADKINS, Christopher James | Secretario | 5 Ray Walk SS9 2NP Leigh On Sea Essex | British | 57087870001 | ||||||
| BELLAMY, Stephen Gerard | Secretario | 220 Forest Road TN2 5HS Tunbridge Wells Kent | New Zealander | 40573970001 | ||||||
| BELLAMY, Stephen Gerard | Secretario | 220 Forest Road TN2 5HS Tunbridge Wells Kent | New Zealander | 40573970001 | ||||||
| BOYD, Christina Kinnel | Secretario | 51 Romulus Court Justin Close TW8 8QW Brentford Middlesex | British | 58475220001 | ||||||
| GUY, Richard John | Secretario | Bridge House Blaisdon GL17 0AH Longhope Gloucestershire | British | 14079450001 | ||||||
| RANDOLPH, Angela Park | Secretario | 4 The Powerhouse 70 Chiswick High Road W4 1SY London | American | 85621330001 | ||||||
| TAYLOR, Charles Miles | Secretario | 36 Church Street GL7 1LE Cirencester Gloucestershire | British | 67499500001 | ||||||
| WELLS, Claire Tytherleigh | Secretario | Rosegarth Brickhouse End Berden CM23 1AZ Bishops Stortford Hertfordshire | British | 49719860001 | ||||||
| WILLIAMS, Mark | Secretario | Allee Du Bois Beson 7840 Louveciennes 7 France | British | 139093880002 | ||||||
| ANDREW, Kenneth, Dr | Director | Amberfield House Amber Lane, Chart Sutton ME17 3SF Maidstone Kent | British | 78357920006 | ||||||
| BARTON, Robert John Orr | Director | 17 Thurloe Square SW7 2TE London | British | 7999080001 | ||||||
| BELLAMY, Stephen Gerard | Director | 220 Forest Road TN2 5HS Tunbridge Wells Kent | England | New Zealander | 40573970001 | |||||
| BREAKIRON, Christopher Paul | Director | c/o Sungard Legal Level 39 Mail Drop 39-50 E14 5LQ London 25 Canada Square United Kingdom | United States Of America | American | 190521150002 | |||||
| BROOMAN, Richard John | Director | 27 Rivermead Court Marlow Bridge Lane SL7 1SJ Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 11328600001 | |||||
| BROWN, Joy Elizabeth | Director | 6 Heather Drive EN2 8LQ Enfield | United Kingdom | English | 92412750001 | |||||
| BRUSH, Leslie Sands | Director | c/o Sungard Legal Level 39 Mail Drop 39-50 E14 5LQ London 25 Canada Square United Kingdom | United States Of America | American | 177318970001 | |||||
| CRAWFORD, Philip James | Director | Cranbourne Lodge Drift Road Winkfield SL4 4RP Windsor Berkshire | England | British | 61146460001 | |||||
| DAVIS, Thomas Ray | Director | 531 Stewards Glen Birmingham Al 35242 United States | American | 92412850001 | ||||||
| DIGIACOMO, David Paul | Director | 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Sungard Legal Level 39 Mail Drop 39-50 London United Kingdom | United States Of America | American | 184271490001 | |||||
| DREW, Stuart Barry | Director | 2 Ashdown Way Kingwood RG9 5WD Henley On Thames | England | British | 36975150003 | |||||
| GROSS, Lawrence Alan | Director | 1433 Evans Road Lower Gwynedd Pennsylvania 19002 Usa | American | 101573650001 | ||||||
| GUY, Richard John | Director | Bridge House Blaisdon GL17 0AH Longhope Gloucestershire | British | 14079450001 | ||||||
| LAMBERT, Martyn John | Director | Loddon Hill Lambs Lane Swallowrfield RG7 1JE Reading Berkshire | England | British | 57006880001 | |||||
| LAVELLE, Gavin Joseph | Director | 15 Lion Gate Gardens TW9 2DW Richmond Surrey | Uk | British | 92186210001 | |||||
| LOEWENBERG, John | Director | 1277 Mariner Court 34990 Palm City Florida Usa | American | 57136260001 | ||||||
| MACLEAN, Peter | Director | Chateauneuf Orchard Chase Tarrant Gunville DT11 8JN Blandford Forum Dorset | British | 29161210001 | ||||||
| MATTHEWS, George Boy | Director | Park House Little Walden CB10 1XA Saffron Walden Essex | British | 29510320001 | ||||||
| MAYO, Marc | Director | Level 39 Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ London Fis Legal Department United Kingdom | United States | American | 203467410001 | |||||
| MCDUGALL, Thomas Joseph | Director | 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London C/O Sungard Legal 39 Mail Drop 39-50 | Usa | United States | 124716760002 | |||||
| MULLANE, Karen Marie | Director | c/o Sungard Legal Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 Mail Drop 39-50 25 United Kingdom | United States Of America | United States | 149766900001 | |||||
| NUSSBAUM, Michael Aaron | Director | Level 39 Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ London Fis Legal Department United Kingdom | Usa | American | 203467380001 | |||||
| OBRIEN, David | Director | Copyhold Chertsey Road GU24 8HS Chobham Surrey | United Kingdom | British | 6759900001 | |||||
| PAYNE, Mark Joseph | Director | c/o Sungard Legal 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 Mail Drop 39-50 | England | British | 130735560001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fis Uk Holdings Limited | 18 sept 2020 | Canada Square E14 5LQ London 25 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Fis Insurance Services Limited | 06 abr 2016 | Canada Square E14 5LQ London 25 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene FIS SHERWOOD SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Creado el 11 nov 2002 Entregado el 15 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All deposits credited to account designation 9109471 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 oct 1991 Entregado el 11 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Flat 42 and parking space 18 telfords yard, 6/8 the highway, wapping, london, E1. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 ene 1990 Entregado el 09 ene 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Stock-in-trade, work in progress, pre-payments, stock exchange, investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 06 may 1987 Entregado el 26 may 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0