ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01817913
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED12 jun 200212 jun 2002
    AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED21 may 198421 may 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2013 au 30 sept 2013

    3 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Andrew Thomson como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 ago 2013

    Estado de capital el 27 ago 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Estado de capital el 24 jun 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Nombramiento de David William Hart Gray como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Gareth Wilson como secretario

    2 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    15 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 30 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Cese del nombramiento de Adrian Stevens como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    17 páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 30 jun 2012 au 31 mar 2012

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Adrian Charles Stevens el 12 sept 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew James Edward Thomson el 12 sept 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Gareth Antony Wilson el 12 sept 2011

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Andrea Fiumicelli el 12 sept 2011

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* el 18 ago 2011

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* el 05 ago 2011

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357740001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishComputer Consultant17678130002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Secretario
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Secretario
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secretario
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Secretario
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    British5361780001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045740001
    CLARKE, Robert Samuel
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishSales & Marketing44712370001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Director
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWLES, Neil
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    Director
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    BritishDirector79753520001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director17678130002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    Director
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    EALES, Gillian Margaret
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    Director
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    BritishBusiness Administrator16296060001
    FRANKS, Nigel
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director39004110002
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Director
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Director
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Director
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Director
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Director
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant178097680001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Director
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    BritishDoctor5361780001
    MORRIS, Eamonn
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector65876940001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RAWCLIFFE, Richard William
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    Director
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    BritishDirector86831530001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Director
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    RICHARDS, Paul
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    Director
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector82595090001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WATSON, Robert John
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director16296070002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Director
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Director
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Director
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002

    ¿Tiene ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 30 dic 2009
    Entregado el 13 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 13 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 01 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of accession
    Creado el 27 nov 2007
    Entregado el 13 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transacciones
    • 13 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Creado el 24 ago 2006
    Entregado el 31 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee and Agent for the Lenders as Defined in the Facility Agreement)(the Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 24 ago 2006
    Entregado el 31 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Creado el 13 abr 2006
    Entregado el 28 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Creado el 08 ago 2002
    Entregado el 16 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 abr 2001
    Entregado el 07 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0