GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED

GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01820848
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 sept 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England el 01 jul 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resolución de insolvencia

    Resolution INSOLVENCY:Extraordinary Resolution ;- "In Specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 jun 2013

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 sept 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Estado de capital el 23 may 2013

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del director Mr Harry Willits el 19 feb 2013

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 71 Queensway London W2 4QH England el 15 feb 2013

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 sept 2010

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Diane Penfold como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Harry Willits como director

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 sept 2009

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Secretario corporativo
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Director
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Director corporativo
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    DIXON, Annie
    23 Mansfield Court
    NE36 0PL West Boldon
    Tyne & Wear
    Secretario
    23 Mansfield Court
    NE36 0PL West Boldon
    Tyne & Wear
    British56380250001
    DIXON, Hedley Marsham
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    British22402950002
    FAGAN, Joyce Helen
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    Secretario
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    British22402970001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Secretario
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Secretario
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Director
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DIXON, Hedley Marsham
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    British22402950002
    FAGAN, Joyce Helen
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    Director
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    British22402970001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Director
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Director
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Director
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Director
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Director
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Director
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Director
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001

    ¿Tiene GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 11 may 2006
    Entregado el 24 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 24 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creado el 27 oct 2005
    Entregado el 09 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 09 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creado el 01 sept 2005
    Entregado el 20 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 20 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 11 feb 2005
    Entregado el 18 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transacciones
    • 18 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 10 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 17 mar 2003
    Entregado el 03 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Including 1-1A north bridge st,monkwearmouth,sunderland SR5 1AD; TY316249; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transacciones
    • 03 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Creado el 21 dic 2000
    Entregado el 11 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Breve descripción
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transacciones
    • 11 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 sept 1995
    Entregado el 16 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 sept 1995
    Entregado el 13 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 1/1A north bridge street monkwearmouth sunderland tyne & wear and A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 feb 1986
    Entregado el 27 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 1 and 1A north bridge street monk wearmouth sunderland tyne and wear and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 1986Registro de una carga
    • 01 dic 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 dic 2013Fecha de disolución
    20 jun 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Profesional
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Profesional
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0