MC (NO 41) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMC (NO 41) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01833366
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MC (NO 41) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MC (NO 41) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5th Floor Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MC (NO 41) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    G.P. FURNISHINGS LIMITED15 dic 199415 dic 1994
    HOMESTORE FURNISHING LIMITED05 dic 198405 dic 1984
    FLAMEYORK LIMITED17 jul 198417 jul 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MC (NO 41) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MC (NO 41) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MC (NO 41) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Stephan Reents el 20 may 2014

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Siegmar Schmidt como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Stephan Reents como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2014

    Estado de capital el 08 ene 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012

    6 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed G.P. furnishings LIMITED\certificate issued on 06/03/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name06 mar 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 feb 2013

    RES15
    change-of-name06 mar 2013

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Estado de capital el 17 dic 2012

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Conflicts of interest 07/12/2012
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Siegmar Theodor Schmidt como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Robins como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Philip Dieperink como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Henry Robins como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 jun 2011

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Steinhoff Uk Group, Northway Lane, Tewkesbury Gloucestershire GL20 8GY* el 07 dic 2011

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director John Henry Robins el 02 nov 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 jun 2010

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de MC (NO 41) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REENTS, Stephan
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    Director
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    GermanyGerman178871420002
    ADAMS, Robert Frank
    The Hall
    LE8 0PG Shangton
    Leicester
    Secretario
    The Hall
    LE8 0PG Shangton
    Leicester
    British154053910001
    ASHCROFT, Mark
    Steinhoff Uk Group, Northway
    Lane, Tewkesbury
    GL20 8GY Gloucestershire
    Secretario
    Steinhoff Uk Group, Northway
    Lane, Tewkesbury
    GL20 8GY Gloucestershire
    British113691350001
    DAVIES, Paul Anthony
    5 The Paddock
    Lois Weedon
    NN12 8QB Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    5 The Paddock
    Lois Weedon
    NN12 8QB Towcester
    Northamptonshire
    British43208330001
    DYSON, Mark Edward
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    Secretario
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    British32670580003
    HANSON, Ian Nigel
    14 Wentworth Avenue
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    14 Wentworth Avenue
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    British1194110001
    MORRISON, Stephen
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    Secretario
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    British97831490001
    ROBINS, John Henry
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    156524200001
    ADAMS, Robert Frank
    The Hall
    LE8 0PG Shangton
    Leicester
    Director
    The Hall
    LE8 0PG Shangton
    Leicester
    EnglandBritish154053910001
    ASHCROFT, Mark
    Steinhoff Uk Group, Northway
    Lane, Tewkesbury
    GL20 8GY Gloucestershire
    Director
    Steinhoff Uk Group, Northway
    Lane, Tewkesbury
    GL20 8GY Gloucestershire
    United KingdomBritish113691350001
    BEE, Simon Frederick Ronald
    The Laurels
    Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    Director
    The Laurels
    Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish2425410001
    CALDWELL, Gordon Stewart
    18 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    Director
    18 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    British73799170001
    CASSIDY, Denis Patrick
    19 Ashburnham Close
    East Finchley
    N2 0NH London
    Director
    19 Ashburnham Close
    East Finchley
    N2 0NH London
    EnglandBritish2425420001
    CLIFFORD-KING, Martin
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British77456620001
    CRIBB, James
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    Director
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    United KingdomBritish15119750004
    DIEPERINK, Philip Jean
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish124398320004
    HANSON, Ian Nigel
    14 Wentworth Avenue
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    14 Wentworth Avenue
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    British1194110001
    KOWALSKI, Timothy John
    Cherry Trees
    Chelford Road
    SK9 7TL Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Cherry Trees
    Chelford Road
    SK9 7TL Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritish64229200003
    MORRISON, Stephen
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    Director
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    British97831490001
    ROBINS, John Henry
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158400410002
    ROSENBLATT, Michael David
    Badgers Rake Woolton Park
    L25 6DX Liverpool
    Merseyside
    Director
    Badgers Rake Woolton Park
    L25 6DX Liverpool
    Merseyside
    British1976970001
    SCHMIDT, Siegmar Theodor
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Festival House
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    5th Floor
    Gloucestershire
    United Kingdom
    GermanyGerman170577250001
    SIMONS, Carolyn
    3 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Director
    3 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63703440003
    TEMPLEMAN, Robert William
    Greenlands Bellwood Court
    ME3 8RT St. Mary Hoo
    Kent
    Director
    Greenlands Bellwood Court
    ME3 8RT St. Mary Hoo
    Kent
    British75683610001
    TUTT, Simon Paul
    25 Wharton Drive
    Beaulieu Park
    SS15 5GX Chelsford
    Essex
    British
    Director
    25 Wharton Drive
    Beaulieu Park
    SS15 5GX Chelsford
    Essex
    British
    British76624840003

    ¿Tiene MC (NO 41) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Part of 73 & 75, knowsley st bolton gt manchester t/n gm 386349.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings forming part of 47-53 (odd) knowsley st bolton gt manchester t/n gm 401530.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    73 & 75 knowlsey st bolton gt manchester t/n gm 390965.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 2 silverdale indust antie silverdale road hayes l/b of hillingdon t/n ngl 375493.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 1 silverdale road hayes l/b of hillingdon t/n ngl 365481.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings forming part of 97-101 (000) bark st bolton gt manchester t/n gm 386272.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 10 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Dolphin house, gorseinon road gorseinon, west glam.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1987Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0