MC (NO 41) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MC (NO 41) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01833366 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MC (NO 41) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MC (NO 41) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5th Floor Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MC (NO 41) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| G.P. FURNISHINGS LIMITED | 15 dic 1994 | 15 dic 1994 |
| HOMESTORE FURNISHING LIMITED | 05 dic 1984 | 05 dic 1984 |
| FLAMEYORK LIMITED | 17 jul 1984 | 17 jul 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MC (NO 41) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MC (NO 41) LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MC (NO 41) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Stephan Reents el 20 may 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Siegmar Schmidt como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Stephan Reents como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed G.P. furnishings LIMITED\certificate issued on 06/03/13 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 dic 2012
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 11 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Siegmar Theodor Schmidt como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Robins como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Dieperink como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Henry Robins como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 jun 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Steinhoff Uk Group, Northway Lane, Tewkesbury Gloucestershire GL20 8GY* el 07 dic 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director John Henry Robins el 02 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 jun 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MC (NO 41) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REENTS, Stephan | Director | Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham 5th Floor Gloucestershire | Germany | German | 178871420002 | |||||
| ADAMS, Robert Frank | Secretario | The Hall LE8 0PG Shangton Leicester | British | 154053910001 | ||||||
| ASHCROFT, Mark | Secretario | Steinhoff Uk Group, Northway Lane, Tewkesbury GL20 8GY Gloucestershire | British | 113691350001 | ||||||
| DAVIES, Paul Anthony | Secretario | 5 The Paddock Lois Weedon NN12 8QB Towcester Northamptonshire | British | 43208330001 | ||||||
| DYSON, Mark Edward | Secretario | The Grange Bewholme YO25 8ED Driffield East Yorkshire | British | 32670580003 | ||||||
| HANSON, Ian Nigel | Secretario | 14 Wentworth Avenue S11 9QX Sheffield South Yorkshire | British | 1194110001 | ||||||
| MORRISON, Stephen | Secretario | 26 Gateacre Rise L25 5LA Liverpool | British | 97831490001 | ||||||
| ROBINS, John Henry | Secretario | Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham 5th Floor Gloucestershire United Kingdom | 156524200001 | |||||||
| ADAMS, Robert Frank | Director | The Hall LE8 0PG Shangton Leicester | England | British | 154053910001 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Director | Steinhoff Uk Group, Northway Lane, Tewkesbury GL20 8GY Gloucestershire | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BEE, Simon Frederick Ronald | Director | The Laurels Fitzroy Road GU51 4JH Fleet Hampshire | United Kingdom | British | 2425410001 | |||||
| CALDWELL, Gordon Stewart | Director | 18 Wood Drive BR7 5EU Chislehurst Kent | British | 73799170001 | ||||||
| CASSIDY, Denis Patrick | Director | 19 Ashburnham Close East Finchley N2 0NH London | England | British | 2425420001 | |||||
| CLIFFORD-KING, Martin | Director | 40 Kings Road HP8 4HS Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 77456620001 | ||||||
| CRIBB, James | Director | Pendeen 28 Caldy Road CH48 2HG West Kirby Merseyside | United Kingdom | British | 15119750004 | |||||
| DIEPERINK, Philip Jean | Director | Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham 5th Floor Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 124398320004 | |||||
| HANSON, Ian Nigel | Director | 14 Wentworth Avenue S11 9QX Sheffield South Yorkshire | British | 1194110001 | ||||||
| KOWALSKI, Timothy John | Director | Cherry Trees Chelford Road SK9 7TL Alderley Edge Cheshire | England | British | 64229200003 | |||||
| MORRISON, Stephen | Director | 26 Gateacre Rise L25 5LA Liverpool | British | 97831490001 | ||||||
| ROBINS, John Henry | Director | Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham 5th Floor Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 158400410002 | |||||
| ROSENBLATT, Michael David | Director | Badgers Rake Woolton Park L25 6DX Liverpool Merseyside | British | 1976970001 | ||||||
| SCHMIDT, Siegmar Theodor | Director | Festival House Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham 5th Floor Gloucestershire United Kingdom | Germany | German | 170577250001 | |||||
| SIMONS, Carolyn | Director | 3 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | 63703440003 | |||||
| TEMPLEMAN, Robert William | Director | Greenlands Bellwood Court ME3 8RT St. Mary Hoo Kent | British | 75683610001 | ||||||
| TUTT, Simon Paul | Director | 25 Wharton Drive Beaulieu Park SS15 5GX Chelsford Essex British | British | 76624840003 |
¿Tiene MC (NO 41) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Part of 73 & 75, knowsley st bolton gt manchester t/n gm 386349. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings forming part of 47-53 (odd) knowsley st bolton gt manchester t/n gm 401530. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 73 & 75 knowlsey st bolton gt manchester t/n gm 390965. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 2 silverdale indust antie silverdale road hayes l/b of hillingdon t/n ngl 375493. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 1 silverdale road hayes l/b of hillingdon t/n ngl 365481. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings forming part of 97-101 (000) bark st bolton gt manchester t/n gm 386272. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 oct 1987 Entregado el 10 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or wades departmental stores limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Dolphin house, gorseinon road gorseinon, west glam. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0