HARBOUR PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HARBOUR PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01833719 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FLAMELINK LIMITED | 18 jul 1984 | 18 jul 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Notification de Dollplace Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jun 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cessation de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jun 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 jun 2023
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital el 08 jun 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Christopher Ralston el 20 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Paul Reed el 20 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Martin Cornell el 20 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Ancosec Limited el 20 sept 2021 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 sept 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG a Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF el 20 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCOSEC LIMITED | Secretario corporativo | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom |
| 111724450001 | ||||||||||
| CORNELL, James Martin | Director | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | England | British | 148803950001 | |||||||||
| RALSTON, Peter Christopher | Director | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 110237280002 | |||||||||
| REED, Robert Paul | Director | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 148032280006 | |||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Secretario | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||||||
| EVANS, David Malcolm | Secretario | Springdale Shobley BH24 3HT Ringwood Hampshire | British | 27482710001 | ||||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Secretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||||||
| LYNE, Sarah Jane | Secretario | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||||||
| READ, Jonathan David | Secretario | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||||||
| SWAIN, John Kenneth | Secretario | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 33262350001 | ||||||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Director | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | 51921200001 | |||||||||
| CHATER, Beth Salena | Director | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 60464290003 | |||||||||
| DEIGMAN, Patrick | Director | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 37099910001 | |||||||||
| DIGBY, Michael Essex | Director | Hillier Parker May & Rowden 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 12476600001 | ||||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Director | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | 49654480002 | |||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Director | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 10297860001 | |||||||||
| FLETCHER, David Jonathan Richard | Director | Stratton House Stratton Street W1X 5FE London | United Kingdom | British | 10597290001 | |||||||||
| JOHNSTON, Andrew James | Director | Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | United Kingdom | British | 131001620001 | |||||||||
| LYALL, Stephen Charles | Director | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 44917590001 | ||||||||||
| MOHANLAL, Satish | Director | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | 51579180001 | ||||||||||
| MURRAY, Nicholas Stuart Granville | Director | Oak House 51 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 29664370001 | |||||||||
| O'SULLIVAN, Michael James | Director | Greenlawns 21 Broad Highway KT11 2RR Cobham Surrey | Australian | 109785090002 | ||||||||||
| PILGRIM, Simon Richard Ellis | Director | Maytrees 27 Portmore Park Road KT13 8ET Weybridge Surrey | British | 16398280001 | ||||||||||
| POPE, Nigel Howard | Director | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | 29583660002 | |||||||||
| PULSFORD, Jeffrey Mark | Director | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | 49776690004 | |||||||||
| ROGERS, Hugh Edward | Director | 24 Sonning Meadows RG4 6XB Sonning Berkshire | British | 13156340003 | ||||||||||
| SADLER, Nicholas James | Director | Clivia Windmill Hill Coleshill HP7 0LZ Amersham Buckinghamshire | British | 38200390001 | ||||||||||
| SMITH, Oliver | Director | 48 Redcliffe Gardens SW10 9HB London | British | 83475590003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollplace Limited | 13 jun 2023 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Services (Uk) Limited | 23 abr 2018 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Developments (2003) | 06 abr 2016 | Central Boulevard Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene HARBOUR PROPERTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 16 nov 1999 Entregado el 19 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999 | |
Breve descripción F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of title deeds | Creado el 29 may 1985 Entregado el 11 jun 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85. | |
Breve descripción Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creado el 30 abr 1985 Entregado el 04 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date | |
Breve descripción Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creado el 30 abr 1985 Entregado el 04 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date | |
Breve descripción Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creado el 30 abr 1985 Entregado el 03 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date | |
Breve descripción Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creado el 30 abr 1985 Entregado el 03 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Breve descripción Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creado el 30 abr 1985 Entregado el 03 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Breve descripción Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 05 feb 1985 Entregado el 05 feb 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge. | |
Breve descripción Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0