HARBOUR PROPERTIES LIMITED

HARBOUR PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHARBOUR PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01833719
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cornwall House Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FLAMELINK LIMITED18 jul 198418 jul 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Notification de Dollplace Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jun 2023

    2 páginasPSC02

    Cessation de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jun 2023

    1 páginasPSC07

    Memorándum y Estatutos

    26 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Conflict of interest 07/06/2023
    RES13
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 jun 2023

    • Capital: GBP 3
    3 páginasSH01

    Estado de capital el 08 jun 2023

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Peter Christopher Ralston el 20 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Robert Paul Reed el 20 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Martin Cornell el 20 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    8 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Ancosec Limited el 20 sept 2021

    1 páginasCH04

    Modification des détails de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 sept 2021

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG a Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF el 20 sept 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ANCOSEC LIMITED
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro3611403
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Director
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    EnglandBritish148803950001
    RALSTON, Peter Christopher
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Director
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish110237280002
    REED, Robert Paul
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Director
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish148032280006
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Secretario
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    EVANS, David Malcolm
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    Secretario
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    British27482710001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Secretario
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Secretario
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    SWAIN, John Kenneth
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Secretario
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British33262350001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Director
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish51921200001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Director
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish60464290003
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37099910001
    DIGBY, Michael Essex
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Director
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British12476600001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Director
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    FLETCHER, David Jonathan Richard
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    Director
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    United KingdomBritish10597290001
    JOHNSTON, Andrew James
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Director
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish131001620001
    LYALL, Stephen Charles
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Director
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British44917590001
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Director
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    British51579180001
    MURRAY, Nicholas Stuart Granville
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish29664370001
    O'SULLIVAN, Michael James
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Director
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Australian109785090002
    PILGRIM, Simon Richard Ellis
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    Director
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    British16398280001
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Director
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritish29583660002
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Director
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish49776690004
    ROGERS, Hugh Edward
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    Director
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    British13156340003
    SADLER, Nicholas James
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    British38200390001
    SMITH, Oliver
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    Director
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    British83475590003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HARBOUR PROPERTIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    13 jun 2023
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5595895
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    23 abr 2018
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3608348
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    Forma jurídicaUnlimited With Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1464587
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HARBOUR PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 16 nov 1999
    Entregado el 19 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999
    Breve descripción
    F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Gamma Holding (UK) Limited
    Transacciones
    • 19 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deposit of title deeds
    Creado el 29 may 1985
    Entregado el 11 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85.
    Breve descripción
    Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570.
    Personas con derecho
    • Jazzman Limited
    Transacciones
    • 11 jun 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Creado el 30 abr 1985
    Entregado el 04 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date
    Breve descripción
    Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180.
    Personas con derecho
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transacciones
    • 04 may 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Creado el 30 abr 1985
    Entregado el 04 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date
    Breve descripción
    Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149.
    Personas con derecho
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transacciones
    • 04 may 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Creado el 30 abr 1985
    Entregado el 03 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date
    Breve descripción
    Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763.
    Personas con derecho
    • Blue Sparkle Investments Limited
    Transacciones
    • 03 may 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Creado el 30 abr 1985
    Entregado el 03 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date.
    Breve descripción
    Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762.
    Personas con derecho
    • Middle East Management Limited
    Transacciones
    • 03 may 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Creado el 30 abr 1985
    Entregado el 03 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date.
    Breve descripción
    Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278.
    Personas con derecho
    • Jazzman Limited
    Transacciones
    • 03 may 1985Registro de una carga
    • 20 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 feb 1985
    Entregado el 05 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge.
    Breve descripción
    Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18).
    Personas con derecho
    • A. J. Peat
    • B. C. Hobbs
    • A. Pascoe Sherlock.
    Transacciones
    • 05 feb 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0