APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAPPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01836659
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHAMROCK LEASING LIMITED29 dic 199729 dic 1997
    APPOLD LEASING LIMITED09 ene 199509 ene 1995
    APPOLD SECURITIES LIMITED06 abr 199206 abr 1992
    HOARE GOVETT SECURITIES LIMITED 13 oct 198613 oct 1986
    HOARE GOVETT MARKET MAKERS LIMITED22 jul 198622 jul 1986
    CHARLES T. PULLEY LIMITED27 jul 198427 jul 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de 2 King Edward Street London EC1A 1HQ a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 30 may 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 03 may 2017

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    6 páginasMR04

    Nombramiento de Jonathan Howard Redvers Lee como director el 26 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Ian Jones como director el 19 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    270 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 abr 2016

    Estado de capital el 06 abr 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2014

    21 páginasAA

    Nombramiento de Philip John Wood como director el 09 jun 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jacob Dutry Van Haeften como director el 07 may 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 abr 2015

    Estado de capital el 29 abr 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Jacob Dutry Van Haeften el 28 feb 2014

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 16 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account reduced to zero 15/10/2014
    RES13

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2013

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Kerry Eamonn O'connell como director el 04 ago 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 abr 2014

    Estado de capital el 15 abr 2014

    • Capital: GBP 73,575,500
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MERRILL LYNCH CORPORATE SERVICES LIMITED
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4929251
    93977210001
    LEE, Jonathan Howard Redvers
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Executive156416990001
    WOOD, Philip John
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Executive173550830001
    CHURCH, Fiona
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Secretario
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    BritishBank Officer116911130001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Secretario
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    BritishChartered Accountant40195710004
    LI, Helene Yuk Hing
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Secretario
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    British147657130001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Secretario
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    British28371200001
    STEVINSON, Jenny
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    Secretario
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    British16404200002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Secretario
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    AmericanBank Official36015120001
    ARNUM, Dennis
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    Director
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    BritishBank Official37241020001
    CLEGG, Simon John
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Director
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    BritishStockbroker61950010001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Director
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant40195710004
    DEYONG, Jacqueline Susan
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    Director
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant25974390001
    DUTRY VAN HAEFTEN, Jacob
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    United KingdomDutchBank Officer172432560002
    DUTTON, Godfrey Thomas
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    Director
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    United KingdomBritishChartered Secretary42461110001
    HOFFMAN, Mark Thomas
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomAmericanBank Officer87065070002
    HOUSTON, Geoffrey Alan
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    BritishStockbroker62886570001
    JONES, Richard Ian
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritishCompany Executive159225600001
    MAZZOLA, Stefano Antonio
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    Director
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    United KingdomBritishStockbroker8890420001
    O'CONNELL, Kerry Eamonn
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritishBank Officer69128130002
    PITHIA, Kantilal Girdharlal
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    Director
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    BritishChartered Accountant68481610001
    SHEALY, Thomas Theodore
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    Director
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    AmericanBank Officer88998990001
    SMITH, Mark Simon Martin
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Director
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    BritishBank Officer121952750001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Director
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    BritishChartered Accountant28371200001
    TETZLAFF, John Stefan Ashby
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Director
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    BritishBank Officer116726040001
    THOMSON, David Fraser
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Executive74549300002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Director
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    AmericanBank Official36015120001
    WESTBROOK, Robert William
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Director
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritishBank Officer169811350001
    WHITAKER, Robert Anthony Mattievich
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    Director
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    BritishStockbroker66770990001
    WITHAM, Geoffrey Alan
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    Director
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    BritishBank Official7752430001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bank Of America Corporation
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    06 abr 2016
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    No
    Forma jurídicaCorporation
    País de registroUnited States Of America / Delaware
    Autoridad legalDelaware General Corporation Law
    Lugar de registroDelaware Secretary Of State
    Número de registroNot Applicable
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 28 feb 1991
    Entregado el 01 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all sums floating charge over stock and other securities (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1991Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 22 jun 1990
    Entregado el 28 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's accounts with and held by the mortgagees (see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transacciones
    • 28 jun 1990Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral agreement
    Creado el 24 feb 1989
    Entregado el 01 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transacciones
    • 01 mar 1989Registro de una carga
    • 31 ene 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Letter agreement
    Creado el 28 jul 1987
    Entregado el 12 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    See form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A.
    Transacciones
    • 12 ago 1987Registro de una carga
    • 31 ene 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 21 jul 1987
    Entregado el 28 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All adrs which were at the date of the security agreement in possession of the chargee and held for the account of the company (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transacciones
    • 28 jul 1987Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 21 jul 1987
    Entregado el 28 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by morgan guaranty trust company in the account (s) in the name of the company denominated "adr pre-release collateral account(s) together with the debts arising therefrom or in respect thereof.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transacciones
    • 28 jul 1987Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 23 oct 1986
    Entregado el 04 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's rights interest & property present and future in all securities transferred to national westminster bank PLC or its nominees by the stock exchange pursuant to any short term certificate issued to the bank in accordance with the provisions of any written agreement relating to non-endorseable short term certificates for the time being in face between the stock exchange, the company & the bank (for details see form 395).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 nov 1986Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge in compliance with the rules and regulations (including council notices) of the stock exchange
    Creado el 23 oct 1986
    Entregado el 03 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All shares stock & other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 dated for 3/11/86 for full details).
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland
    Transacciones
    • 03 nov 1986Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 07 nov 1985
    Entregado el 25 nov 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all securities transferred to the company or its nominees of the stock exchange present to any short term certificate issued to national westminster bank PLC. See doc M10 for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 nov 1985Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 08 ago 1985
    Entregado el 19 ago 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see doc M9 for details).
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange
    Transacciones
    • 19 ago 1985Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 01 ago 1984
    Entregado el 17 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The securities therein defined together with all benefits arising therefrom and not transferred by the stock exchange to the company for details see doc M8.
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange
    Transacciones
    • 17 ago 1984Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation
    Creado el 01 ago 1984
    Entregado el 17 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For varying the terms of the principal charge of even date
    Breve descripción
    The deed varis the definition of the securities which are subject to the principal charge and also affects the ranking of the principal charge and certain charges in favour of other parties.
    Personas con derecho
    • The Stock Exchange
    Transacciones
    • 17 ago 1984Registro de una carga
    • 07 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 01 ago 1984
    Entregado el 16 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all shares stock and other securities of any class or description which are from time to time included in and evidenced by any current collateral certificate or supplemental collateral certificate issued pursuant to any operating agreement in writing for further details see doc M6.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1984Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 may 2017Inicio de la liquidación
    07 feb 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0