RECONDO (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRECONDO (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01848155
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RECONDO (UK) LIMITED?

    • (2922) /

    ¿Dónde se encuentra RECONDO (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Sell Close
    Cheshunt
    EN7 6XE Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RECONDO (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REDIRACK (UK) LIMITED24 mar 200324 mar 2003
    REDIRACK LIMITED04 ene 198804 ene 1988
    REDIRACK INTERLAKE LIMITED31 dic 198431 dic 1984
    PRECIS (329) LIMITED14 sept 198414 sept 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RECONDO (UK) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2009
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2010
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RECONDO (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Geir Drangeid como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Steinar Hausberg Vatle como director

    3 páginasAP01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    2 páginasDS02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    9 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    9 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    9 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    9 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de RECONDO (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEESE, Andrew Stephen
    1 Sell Close
    EN7 6XE Cheshunt
    Hertfordshire
    Secretario
    1 Sell Close
    EN7 6XE Cheshunt
    Hertfordshire
    British112184900001
    REVHAUG, Olav
    N-1878 Hearland
    Haerland
    Norway
    Director
    N-1878 Hearland
    Haerland
    Norway
    NorwayNorwegianDirector70225780001
    VATLE, Steinar Hausberg
    1 Sell Close
    Cheshunt
    EN7 6XE Hertfordshire
    Director
    1 Sell Close
    Cheshunt
    EN7 6XE Hertfordshire
    NorwayNorwegianNone162452370001
    FORSYTHE, Andrew
    Pine Lodge
    2b Coral Close
    LE10 2HB Burbage Hinckley
    Leicestershire
    Secretario
    Pine Lodge
    2b Coral Close
    LE10 2HB Burbage Hinckley
    Leicestershire
    BritishLawyer104718290001
    FOSTER, Alison Taylor
    136 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    136 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    British62154470001
    WATTS, John
    26 Field House Lane
    Sprotbrough
    DN4 7RP Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    26 Field House Lane
    Sprotbrough
    DN4 7RP Doncaster
    South Yorkshire
    British96747260001
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Secretario
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    British6916040002
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Secretario
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    British6916040002
    APPLETON, Kevin Andrew
    Dormer House
    Cumnor Hill
    OX2 9JA Oxford
    Oxfordshire
    Director
    Dormer House
    Cumnor Hill
    OX2 9JA Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector67821450002
    COUTTS, Neil Mccrone
    St Dunstans House
    Mill Lane Monks
    HP27 9JE Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    St Dunstans House
    Mill Lane Monks
    HP27 9JE Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector43075390001
    CULLING, Philip John
    Long Garth Cottage
    12 Westgate Tickhill
    DN11 9NE Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    Long Garth Cottage
    12 Westgate Tickhill
    DN11 9NE Doncaster
    South Yorkshire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishManaging Director47982640003
    CULLING, Philip John
    The Barns 39 High Street
    Braithwell
    S66 7AW Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    The Barns 39 High Street
    Braithwell
    S66 7AW Rotherham
    South Yorkshire
    BritishSales & Marketing Dir47982640002
    DRANGEID, Geir Arne
    Arnulf Overlandsvei 214
    FOREIGN No_0763 Oslo
    Norway
    Director
    Arnulf Overlandsvei 214
    FOREIGN No_0763 Oslo
    Norway
    NorwayNorwegianVice President127668990001
    HEY, John Stephen Paul
    8 Hopping Lane
    N1 2NU London
    Director
    8 Hopping Lane
    N1 2NU London
    BritishDivisional Fd71286180001
    HINCHLIFF, Stephen
    Bowmore Farm
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    Bowmore Farm
    Hawridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Buckinghamshire
    BritishDirector1451770001
    MARTINSON, Simon Nyquist
    Hvitveisstein 2
    1346 Gjettum
    Norway
    Director
    Hvitveisstein 2
    1346 Gjettum
    Norway
    NorwegianSenior Vice President96749250001
    MILLER, Stuart Purves
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector98718070001
    MONTAGUE, Andrew Michael
    The Shieling
    Barford Road
    OX5 4QY Hempton
    Oxford
    Director
    The Shieling
    Barford Road
    OX5 4QY Hempton
    Oxford
    BritishDirector12852080001
    MURI, Hallvard
    PO BOX 1423 Vika
    FOREIGN O115 Oslo
    Norway
    Director
    PO BOX 1423 Vika
    FOREIGN O115 Oslo
    Norway
    NorwegianCompany Director92893310001
    OSMAN, Wayne Miles
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    Director
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    BritishManaging Director37925180001
    PAUWELS, Willem Emiel
    Stuivenbergvaart 69
    Mechelen
    2800
    Belgium
    Director
    Stuivenbergvaart 69
    Mechelen
    2800
    Belgium
    BelgianCompany Director77146170001
    PIACENTI, Vincent Edward
    142-146 Fishpool Street
    AL3 4RZ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    142-146 Fishpool Street
    AL3 4RZ St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector20998310002
    REM, Bengt Arve
    Chr.Michelsensv 39
    No-1472 Fjellhamar
    Norway
    Director
    Chr.Michelsensv 39
    No-1472 Fjellhamar
    Norway
    NorwegianFinancial Officer127668120001
    SJURSEN, Frode
    Valhallvn 4c
    3500 Honefoss
    Norway
    Director
    Valhallvn 4c
    3500 Honefoss
    Norway
    NorwegianChief Executive62938670001
    SMITH, Nicholas Ralph
    1 Tompkins Close
    HP22 5WH Aston Clinton
    Buckinghamshire
    Director
    1 Tompkins Close
    HP22 5WH Aston Clinton
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer72551500001
    STILLER, Bernd Wenzel Paul
    Beethovenstrasse 4
    6312 Laubach
    Germany
    Director
    Beethovenstrasse 4
    6312 Laubach
    Germany
    GermanDirector33839420001
    VAN ENGELAND, Maarten
    Avej 20a
    FOREIGN 3500 Vaerlose
    Denmark
    Denmark
    Director
    Avej 20a
    FOREIGN 3500 Vaerlose
    Denmark
    Denmark
    DutchDirector64878410001
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Director
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    EnglandBritishCompany Secretary6916040002

    ¿Tiene RECONDO (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over credit balances
    Creado el 21 dic 1995
    Entregado el 10 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond dated 16 may 1995 in favour of amec design & management LTD for £12,090
    Breve descripción
    The sum of £12,090 together with interest accrued now or to be held by the bank on an accounbt numbered 72286342 and earmarked by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 21 dic 1995
    Entregado el 29 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All liabilities of the company present and future actual and/or contingent to the chargee in relation to a guarantee dated 23 october 1995 in of s&l united storage limited for £68,955.17
    Breve descripción
    The sum of £68,955.17 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 72304561 and earmarked or designated by reference to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 21 dic 1995
    Entregado el 29 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 23 october 1995 in favour of caberboard limited for £13,512.50
    Breve descripción
    The sum of £13,512.50 together with interest held by the bank on an account numbered 72304596 and designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 23 nov 1995
    Entregado el 28 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to performance guarantee bond in favour of alfred mcalpine construction limited for £25,152.90
    Breve descripción
    The sum of £25,152.90 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 72309253 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 29 jun 1995
    Entregado el 20 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to an advance payment guarantee in favour of B.I.G. batteries limited for £65,212.50
    Breve descripción
    The sum of £65,212.50 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 72294159 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 05 may 1995
    Entregado el 26 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond in favour of amec design and management limited for £12,090
    Breve descripción
    The sum of £12,090 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 72286342 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 20 jun 1994
    Entregado el 29 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance guarantee dated 14/4/94 in favour of bicc group pension trust for £133,602.00.
    Breve descripción
    The sum of £133,602.00 tgether with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 72238909 and earmarked or designatedby reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0