HARPER GROUP PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHARPER GROUP PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 01854872
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HARPER GROUP PLC?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra HARPER GROUP PLC?

    Dirección de la sede social
    Units 1 & 2 Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    West Midlands
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARPER GROUP PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ELVATON LIMITED12 oct 198412 oct 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HARPER GROUP PLC?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HARPER GROUP PLC?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta04 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence18 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta04 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARPER GROUP PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    21 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Anthony Paul Rees el 29 feb 2024

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Nigel Mondon como director el 28 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Nigel Mondon como secretario el 28 feb 2020

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    23 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Beeches Road Rowley Regis Warley West Midlands B65 0BB a Units 1 & 2 Bevan Industrial Estate Brierley Hill West Midlands DY5 3TF el 18 ago 2017

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    24 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jun 2016

    Estado de capital el 06 jun 2016

    • Capital: GBP 599,508
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    22 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 jun 2015

    Estado de capital el 10 jun 2015

    • Capital: GBP 599,508
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 jun 2014

    Estado de capital el 25 jun 2014

    • Capital: GBP 599,508
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de HARPER GROUP PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OVERTON, Victoria Jane
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Secretario
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    British97258880003
    HARVEY, Michael
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Director
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector70216940003
    OVERTON, Victoria Jane
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Director
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector97258880003
    REES, Anthony Paul
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Director
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector95309560006
    LENNOCK, Mark William
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    Secretario
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    BritishInvestment Manager2069680006
    MONDON, Peter Nigel
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Secretario
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    BritishCo Director Construction51801010002
    ROBINSON, Michael Albert
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    British11309240001
    TAYLOR, Kevin Trevor
    107 Fallowfield Road
    B63 1BY Halesowen
    West Midlands
    Secretario
    107 Fallowfield Road
    B63 1BY Halesowen
    West Midlands
    British63465950001
    AMOS, Raymond Leslie
    Tall Pines Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    Director
    Tall Pines Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    BritishManaging Director12219390001
    HARPER, Joseph Donald
    Fulhams Mews
    Kyre
    WR15 8RN Tenbury Wells
    Worcestershire
    Director
    Fulhams Mews
    Kyre
    WR15 8RN Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishBuilder12219400001
    HARPER, Joseph Stuart
    218 Bromsgrove Road
    Hunnington
    B62 0JS Halesowen
    West Midlands
    Director
    218 Bromsgrove Road
    Hunnington
    B62 0JS Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritishSurveyor11309270001
    HARPER, Leonard Frank
    Brackens
    Mucklow Hill
    B62 8NX Halesowen
    West Midlands
    Director
    Brackens
    Mucklow Hill
    B62 8NX Halesowen
    West Midlands
    BritishBuilder11318970001
    LENNOCK, Mark William
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    Director
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishInvestment Manager2069680006
    MONDON, Peter Nigel
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Director
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    EnglandBritishCo Director Construction51801010002
    MONDON, Peter Nigel
    13 Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    Salop
    Director
    13 Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    Salop
    BritishCompany Director51801010001
    REES, Walter Paul
    Buckfield House Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    Director
    Buckfield House Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    BritishQuantity Surveyor11309290001
    ROBINSON, Michael Albert
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    BritishChartered Accountant11309240001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Director
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishCompany Director17203000001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HARPER GROUP PLC?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Beeches Road
    B65 0BB Rowley Regis
    101
    England
    06 abr 2016
    Beeches Road
    B65 0BB Rowley Regis
    101
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06892284
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene HARPER GROUP PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 oct 2007
    Entregado el 24 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mrs Susan Ingrid Underhill
    Transacciones
    • 24 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 mar 2006
    Entregado el 30 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal su of £2,691,497.00 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Old Mill Construction Limited
    Transacciones
    • 30 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 jul 2004
    Entregado el 16 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alvin Joseph Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Godfrey Charles Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Rowland William Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Clive Dean Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 2 february 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Leonard Frank Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Joseph Donald Harper
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fiona Jane Burton
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 ago 1994
    Entregado el 07 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Peter John Underhill
    Transacciones
    • 07 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 ago 1994
    Entregado el 07 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mark William Lennock
    Transacciones
    • 07 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Wyncote beeches road rowley regis warley west midlands t/n WR12352.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    100 beeches road rowley regis west midlands t/n WR10328.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    99 beeches road rowley regis warley west midlands t/n WM38310.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 02 sept 1993
    Entregado el 13 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the deposits together with all interest (account no 70147230). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creado el 07 jun 1985
    Entregado el 14 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jun 1985Registro de una carga
    • 19 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0