SHEFFIELD LAW CENTRE
Visión general
| Nombre de la empresa | SHEFFIELD LAW CENTRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 01859060 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SHEFFIELD LAW CENTRE?
- Notarios (69102) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Dirección de la sede social | Waverley House 10 Joiner Street S3 8GW Sheffield. |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SHEFFIELD LAW CENTRE LIMITED | 26 oct 1984 | 26 oct 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Emerson como director el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Edmund Brian Greenwood como director el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Benjamin Whiteley como director el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 27 ene 2014, aucune liste de membres fournie | 9 páginas | AR01 | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 15 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 27 ene 2013, aucune liste de membres fournie | 12 páginas | AR01 | ||
Cese del nombramiento de Catherine Lesley Rogers como director el 26 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Rowland Cole como director el 26 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Elisabeth Petrie como director el 26 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sean Douglas Markham como director el 26 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Jane Elizabeth Emerson como director el 04 ene 2013 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Benjamin Whiteley como director el 04 ene 2013 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Keith Henry Baker como director el 15 dic 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Tobias William Pochron como director el 04 ene 2013 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Edmund Brian Greenwood como director el 04 ene 2013 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mujangi Jacques Kalenga como director el 01 ene 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Anwar como director el 01 ene 2013 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 16 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Saeed Abdi como director el 01 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 27 ene 2012, aucune liste de membres fournie | 10 páginas | AR01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SHEFFIELD LAW CENTRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON, Patricia Anne | Secretario | 66 Ridal Avenue Stocksbridge S36 1EZ Sheffield | British | 59779530003 | ||||||
| BAKER, Keith Henry | Director | Hillcote Close S10 3PT Sheffield 75 England | England | British | 174826090001 | |||||
| POCHRON, Tobias William | Director | 3 Edmund Court Apartment 13 S2 4DP Sheffield 3 England | England | British | 174825970001 | |||||
| WINDLE, Marcus Ralph | Director | 25 Verdon Street S3 9QS Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 60955430001 | |||||
| CIRKET, Catherine Cecilia | Secretario | 266 Bannerdale Road S11 9FE Sheffield South Yorkshire | British | 52423060002 | ||||||
| CUNNINGHAM, Christopher | Secretario | 3 Burnside Avenue Meersbrook S8 9FR Sheffield | British | 60748450001 | ||||||
| ELDRIDGE, William Leigh | Secretario | 144 Halifax Road S6 1LH Sheffield | British | 63357700001 | ||||||
| EMERSON, Jane | Secretario | 80 Wath Road S7 1HE Sheffield South Yorkshire | British | 78771990001 | ||||||
| FITZPATRICK, Kathleen Mary | Secretario | 87 Foulden Road N16 7UH London | British | 71178400001 | ||||||
| JOHNSON, Douglas James Preston | Secretario | 191 Fox Street S3 9HD Sheffield | British | 60955530001 | ||||||
| LOVETT, Isobel | Secretario | 40 Stewart Road Hunters Bar S11 8XT Sheffield | British | 42133060002 | ||||||
| MAJOR, Maureen Jean | Secretario | 30 Ravenscroft Avenue S13 8PL Sheffield South Yorkshire | British | 76147950001 | ||||||
| ROBERTS, Joanne Louise | Secretario | Sarum House Aldwarke Road S62 6BZ Rotherham South Yorkshire | British | 98029670001 | ||||||
| SADIQ, Abda | Secretario | 292 Batemoor Road Batemoor S8 8FX Sheffield South Yorkshire | British | 46601360001 | ||||||
| STUBBS, Jacqueline | Secretario | 85 Underwood Road S8 8TG Sheffield South Yorkshire | British | 17973780001 | ||||||
| WRIGHT, Ann Margaret | Secretario | 10 Grange Crescent Road S11 8FX Sheffield South Yorkshire | British | 57859090001 | ||||||
| ABDI, Saeed | Director | 31 Lyons Road S4 7EL Sheffield | United Kingdom | British | 61991810002 | |||||
| ABDI, Saeed | Director | 21 Clun Street S4 7JS Sheffield | Somali | 61991810001 | ||||||
| ALAM, Surat | Director | 1 Deepdale Villas Finchwell Road S13 9AS Sheffield South Yorkshire | British | 71177950001 | ||||||
| ALTAF, Mohammad | Director | 46 Clipstone Road S9 5ET Sheffield South Yorkshire | British | 48819830001 | ||||||
| ANJAB, Mohammed Ali | Director | 6 Uttley Drive S9 5BZ Sheffield South Yorkshire | British | 78651830001 | ||||||
| ANWAR, Philip | Director | 2 Endcliffe Vale Road S10 3EQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 117866380001 | |||||
| BADDELEY, Guy Alexander | Director | 45 Edge Hill Road S7 1SP Sheffield South Yorkshire | British | 76673740001 | ||||||
| BALL, John | Director | 26 Studfield Road S6 4ST Sheffield South Yorkshire | British | 107383830001 | ||||||
| BALL, Tina | Director | 434 Grimesthorpe Road S4 8LE Sheffield South Yorkshire | British | 95632580001 | ||||||
| BROWN, Robert Patrick | Director | Montagu House Heeley Bank Road S2 3GL Sheffield South Yorkshire | British | 127580410001 | ||||||
| BRYCE, Amanda | Director | 48 Hunter House Road S11 8TW Sheffield South Yorkshire | British | 23627180001 | ||||||
| CAINE, Clinton Orville | Director | 220 Bannerdale Road S11 9FE Sheffield South Yorkshire | British | 30330460001 | ||||||
| CAMPBELL, John | Director | 194 Longley Lane S5 7JG Sheffield Yorkshire | England | British | 95589970001 | |||||
| CARTER, Trevor | Director | 90 Larch Hill Handsworth S9 4AJ Sheffield South Yorkshire | British | 99164810001 | ||||||
| CASEY, Gerard Anthony | Director | 23 Peterborough Road S10 4JD Sheffield | Irish | 38037580001 | ||||||
| CAVANAGH, Russell | Director | 30 Rushdale Road S8 9QB Sheffield South Yorkshire | British | 87745770001 | ||||||
| CIRKET, Catherine Cecilia | Director | 266 Bannerdale Road S11 9FE Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 52423060002 | |||||
| COLE, Christopher Rowland | Director | Progress Drive Bramley S66 1TT Rotherham 54 South Yorkshire | England | British | 87745560003 | |||||
| COULTER, Tanya | Director | 21 Violet Bank Road S7 1RZ Sheffield South Yorkshire | Irish | 23627200001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0