TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED

TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01863110
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o SCA
    1 Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    Bedfordshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EPS (MOULDERS) LIMITED05 jun 198505 jun 1985
    TRUESTAR LIMITED13 nov 198413 nov 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 oct 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 16 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jul 2012

    Estado de capital el 27 jul 2012

    • Capital: GBP 253,551
    SH01

    Nombramiento de Mrs Sally Anne Barker como director el 30 jun 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Andrew Bailey como director el 30 jun 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Andrew Bailey como secretario el 30 jun 2012

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Victoria Sykes como secretario el 30 jun 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Thomas David Heys como director el 30 jun 2012

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Sca Packaging Limited Faverdale Industrial Estate Darlington DL3 0PE el 27 jul 2012

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Stephen Paul Hovington como director el 30 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAILEY, Paul Andrew
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Secretario
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    170967330001
    BAILEY, Paul Andrew
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Director
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish75085210004
    BARKER, Sally Anne
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Director
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish136081340002
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Secretario
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    MILLER, Charles
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    Secretario
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    British15424600001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Secretario
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    SYKES, Victoria
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    Secretario
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    British138121210001
    TILLSON, Andrew John
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    Secretario
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    British54524940001
    BIDDINGER, Scott
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    Director
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    American49882470001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Director
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritish133589280001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Director
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritish60781190001
    HUNTER, Martin
    79 Drum Brae South
    EH12 8TD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    79 Drum Brae South
    EH12 8TD Edinburgh
    Midlothian
    British15424610001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Director
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    British28463460001
    MILLER, Charles
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    Director
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    British15424600001
    MULLINS, Brian Christopher
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Director
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen49882440001
    O'LEARY JR, John Patrick
    13 Davidson Drive
    15010 Beaver Falls
    Pennsylvania
    Usa
    Director
    13 Davidson Drive
    15010 Beaver Falls
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen41699650001
    O`LEARY, David Carl
    360 River Road
    15009 Beaver
    Pennsylvania
    Usa
    Director
    360 River Road
    15009 Beaver
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen49992870001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish108501020001
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Director
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish72400470001
    STOTT, Alan
    12 Balmoral Drive
    Denton
    M34 2JU Manchester
    Lancashire
    Director
    12 Balmoral Drive
    Denton
    M34 2JU Manchester
    Lancashire
    British15424630001
    THYNE, William
    The Yair
    TD1 3PW Galashiels
    Director
    The Yair
    TD1 3PW Galashiels
    ScotlandBritish285450001
    WHYTE, Frederick Gordon
    1 Sycamore Gardens
    EH12 7JJ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    1 Sycamore Gardens
    EH12 7JJ Edinburgh
    Midlothian
    British577600001
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Director
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British74014480001

    ¿Tiene TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security registered in scotland 26/11/90
    Creado el 26 nov 1990
    Entregado el 06 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 26/11/90
    Breve descripción
    All and whole the dominium utile of that area or piece of ground lying on the south east side of firth road, houstoun industrial estate, livingston in the parish of mid-calder and county of midlothian extending to 4 acres or thereby together with the factory k/a 15 firth road, and the whole other buildings erected thereon.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 dic 1990Registro de una carga
    • 27 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creado el 22 may 1990
    Entregado el 01 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and whole the dominion utile of piece of ground lying to the south of grange road houstoun industrial estate west lothian k/a standard factory five "a" and the building erected thereon.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 01 jun 1990Registro de una carga
    • 26 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 15 may 1985
    Entregado el 20 may 1985
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 13 may 1985 was registered pursuant to section 95 of the companies act 1948, on 20 may 1985.
    Breve descripción
    All right, title & interest incorporated in the lease dated 28 august. (See doc M11 for full details).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 may 1985Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 03 abr 1985
    Entregado el 23 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The whole property and undertaking of the company including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 abr 1985Registro de una carga
    • 26 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 may 2013Fecha de disolución
    31 oct 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0