EX-CELL-O (UK) LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEX-CELL-O (UK) LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01866181
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EX-CELL-O (UK) LTD?

    • (2852) /

    ¿Dónde se encuentra EX-CELL-O (UK) LTD?

    Dirección de la sede social
    c/o BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    St. Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EX-CELL-O (UK) LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARVID MACHINERY SYSTEMS LIMITED 12 abr 198812 abr 1988
    SUNDERLAND MACHINE DESIGN AND CONSULTANCY LIMITED23 nov 198423 nov 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EX-CELL-O (UK) LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EX-CELL-O (UK) LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    15 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 sept 2011

    15 páginas4.68

    Orden judicial que concede al liquidador voluntario permiso para renunciar

    1 páginas4.35

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    6 páginasLIQ MISC OC

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 sept 2010

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Fourth Floor Fort Dunlop Fort Parkway Birmingham West Midlands B24 9FD el 11 oct 2010

    2 páginasAD01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 oct 2009

    • Capital: GBP 814,150
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Section 550
    RES13

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    8 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    21 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    23 páginasAA

    legacy

    1 páginas403a

    ¿Quiénes son los directivos de EX-CELL-O (UK) LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Secretario
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    BritishDirector135386290001
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Director
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director135386290001
    HAGENAU, Gerhard
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    Director
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    GermanyGermanChief Financial Officer139197540001
    BROWN, Harry
    1 Greetlands Road
    Tunstall
    SR2 9EB Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Greetlands Road
    Tunstall
    SR2 9EB Sunderland
    Tyne & Wear
    British16198420001
    GAUNT, Michael Ian
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Secretario
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    BritishController113180730001
    GOOD, Ian Scott
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishHr Director106898310001
    MEHLING, Hans Hubert
    Jahnstrasse 16
    Donzdorf
    Bad Wenhambery
    Germany
    Secretario
    Jahnstrasse 16
    Donzdorf
    Bad Wenhambery
    Germany
    GermanVice President Finance30980770001
    SCHMID, Jorg
    Geierweg 28
    Aalen
    Baden Wurttemberg 73434
    Germany
    Secretario
    Geierweg 28
    Aalen
    Baden Wurttemberg 73434
    Germany
    GermanDirector78352830001
    SPLEISS, Roland
    Berliner Str 3a
    Waldenbuch
    Baden-Wuritemberg 7111
    Germany
    Secretario
    Berliner Str 3a
    Waldenbuch
    Baden-Wuritemberg 7111
    Germany
    GermanCfo107370480001
    BENJAMIN, James Cover
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    Director
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    AmericanExecutive Vp104568880001
    BENNETT, Maurice
    10 Condover Park
    Condover
    SY5 7DU Shrewsbury
    Salop
    Director
    10 Condover Park
    Condover
    SY5 7DU Shrewsbury
    Salop
    BritishManaging Director Engineer29132860001
    BROWN, Harry
    1 Greetlands Road
    Tunstall
    SR2 9EB Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Greetlands Road
    Tunstall
    SR2 9EB Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishEngineer16198420001
    COPE, Roger
    3730 Rock Valley Road
    Metamora
    Michigan 48455
    Usa
    Director
    3730 Rock Valley Road
    Metamora
    Michigan 48455
    Usa
    UsaBusiness Executive113180750001
    ENGEL, Heinrich
    Kirchstr 51 73113 Wangen
    73054 Eislingen
    Ba Wu
    Germany
    Director
    Kirchstr 51 73113 Wangen
    73054 Eislingen
    Ba Wu
    Germany
    GermanGeneral Manager52435740001
    GAUNT, Michael Ian
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Director
    31 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishController113180730001
    GOOD, Ian Scott
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    63 Sir Alfreds Way
    Newhall
    B76 1ET Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishHr Director106898310001
    HORN, Wolfgang, Dr Ing
    Rechberghauser Weg 2
    Goppingen
    Baden-Wurttemberg 73053
    Germany
    Director
    Rechberghauser Weg 2
    Goppingen
    Baden-Wurttemberg 73053
    Germany
    GermanDirector79041140001
    KOCH, Thomas, Dr
    Hofbaumgarten 40
    Kirchheim
    Baden-Wurttemberg 73230
    Germany
    Director
    Hofbaumgarten 40
    Kirchheim
    Baden-Wurttemberg 73230
    Germany
    GermanDirector78835230001
    MANTLE, Neil
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Director
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    BritishManaging Director124095260001
    MEHLING, Hans Hubert
    Jahnstrasse 16
    Donzdorf
    Bad Wenhambery
    Germany
    Director
    Jahnstrasse 16
    Donzdorf
    Bad Wenhambery
    Germany
    GermanVice President Finance30980770001
    NAHL, Jochen
    Sonderbachstrabe 15
    Waeschenbeuren
    Baden Wuerttemberg 73116
    Germany
    Director
    Sonderbachstrabe 15
    Waeschenbeuren
    Baden Wuerttemberg 73116
    Germany
    GermanDirector68063050001
    RAJIC, Fedur
    380 Pelissier Street
    Apt 1506
    FOREIGN Windsor
    Ontario N9a 6v7
    Canada
    Director
    380 Pelissier Street
    Apt 1506
    FOREIGN Windsor
    Ontario N9a 6v7
    Canada
    CanadianCorporate Executive16198430001
    RUDDOCK, Alan
    25 Grove Park Avenue
    West Derby
    L12 5JP Liverpool
    Director
    25 Grove Park Avenue
    West Derby
    L12 5JP Liverpool
    BritishExecutive Vp35199050001
    RUF, Matthias
    Schweitzer- Str. 43
    Stuttart
    Baden-Wuerttemberg 70619
    Germany
    Director
    Schweitzer- Str. 43
    Stuttart
    Baden-Wuerttemberg 70619
    Germany
    GermanFinance And Accounting Manager110295290001
    SCHMID, Jorg
    Geierweg 28
    Aalen
    Baden Wurttemberg 73434
    Germany
    Director
    Geierweg 28
    Aalen
    Baden Wurttemberg 73434
    Germany
    GermanDirector78352830001
    SCHMIDT, Werner
    Oberer Graben 13
    77963 Schwanau Frg
    73054 Eislingen Fils
    Ba Wu
    Germany
    Director
    Oberer Graben 13
    77963 Schwanau Frg
    73054 Eislingen Fils
    Ba Wu
    Germany
    GermanGeneral Manager50975910001
    SCHMUECKING, Rudolf
    Cranachweg 4
    Goeppingen
    Baden Wuerttemberg 73033
    Germany
    Director
    Cranachweg 4
    Goeppingen
    Baden Wuerttemberg 73033
    Germany
    GermanDirector68063290001
    SPLEISS, Roland
    Berliner Str 3a
    Waldenbuch
    Baden-Wuritemberg 7111
    Germany
    Director
    Berliner Str 3a
    Waldenbuch
    Baden-Wuritemberg 7111
    Germany
    GermanCfo107370480001
    VUKELIC, Branco
    9099 Riverside Drive East
    Apt 1321 E
    FOREIGN Windsor
    Ontario
    Canada
    Director
    9099 Riverside Drive East
    Apt 1321 E
    FOREIGN Windsor
    Ontario
    Canada
    CanadianCorporate Executive16198440001
    WELLS, David Keith
    44 Castle Nurseries
    GL55 6JT Chipping Campden
    Gloucestershire
    Director
    44 Castle Nurseries
    GL55 6JT Chipping Campden
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director69286440002

    ¿Tiene EX-CELL-O (UK) LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Consolidated amended and restated security agreement
    Creado el 27 abr 2006
    Entregado el 16 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A security interest in and lien upon all of its right, title and interest in, to and under all personal property and other assets, whether then owned by or owing to, or thereafter acquired by or arising in favour of the grantor and whether owned or consigned by or to, or leased from or to, the grantor, and regardless of where located (the collateral). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transacciones
    • 16 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Consolidated amended and restated patent and trademark security agreement
    Creado el 27 abr 2006
    Entregado el 16 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its owned and thereafter acquired or arising and filed patnets and patent applications and all of its patent licenses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transacciones
    • 16 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Consolidated amended and restated copyright security agreement
    Creado el 27 abr 2006
    Entregado el 16 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its then owned and thereafter acquired or arising and registered copyrights, all copyright licences to which it is a party and all license fees and royalties arising. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transacciones
    • 16 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 abr 2006
    Entregado el 12 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any credit party to the agents or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Silver Point Finance, Llc as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders
    Transacciones
    • 12 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene EX-CELL-O (UK) LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2
    FechaTipo
    11 abr 2012Fecha de disolución
    27 sept 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Profesional
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Lynn Robert Bailey
    St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Profesional
    St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Graham Paul Bushby
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Profesional
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0