CENTRAL WEIGHING LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRAL WEIGHING LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01869891
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRAL WEIGHING LTD?

    • fabricación de equipos electrónicos de medición, prueba, etc., no para control de procesos industriales (26511) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CENTRAL WEIGHING LTD?

    Dirección de la sede social
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CENTRAL WEIGHING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CENTRAL WEIGHING CONSULTANTS LIMITED07 dic 198407 dic 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRAL WEIGHING LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRAL WEIGHING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 02 jul 2013

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    £59200 to credit of share prem cancelled 28/06/2013
    RES13

    Cese del nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director el 31 mar 2013

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2012 au 31 dic 2012

    1 páginasAA01

    legacy

    3 páginasMG02

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03

    Nombramiento de S & J Registrars Limited como secretario el 28 may 2012

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director el 28 may 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Giles Matthew Hudson como director el 28 may 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Edward Ufland como director el 28 may 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pauline Vera Stokes como director el 28 may 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard William Stokes como director el 28 may 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director el 28 may 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Ball como secretario el 28 may 2012

    1 páginasTM02

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRAL WEIGHING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01740543
    43122090005
    DEAKIN, Philip Matthew
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish161583790003
    UFLAND, Edward
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish87558180001
    BALL, Ian
    9 Oakdale Close
    Pensnett
    DY5 4PY Brierley Hill
    West Midlands
    Secretario
    9 Oakdale Close
    Pensnett
    DY5 4PY Brierley Hill
    West Midlands
    British121775640001
    JACKSON, Peter Stephen
    The Corner House
    16 Newtown
    SG4 8UQ Codicote
    Hertfordshire
    Secretario
    The Corner House
    16 Newtown
    SG4 8UQ Codicote
    Hertfordshire
    British4425080001
    LANGFORD, Philip James Deverell, Mr.
    Highfield 90 Harmer Green Lane
    AL6 0EP Welwyn
    Hertfordshire
    Secretario
    Highfield 90 Harmer Green Lane
    AL6 0EP Welwyn
    Hertfordshire
    British34943510001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Secretario corporativo
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    66216820001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Unit 142 Hartlebury Trading
    Estate, Hartlebury
    DY10 4JB Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    JACKSON, Peter Stephen
    The Corner House
    16 Newtown
    SG4 8UQ Codicote
    Hertfordshire
    Director
    The Corner House
    16 Newtown
    SG4 8UQ Codicote
    Hertfordshire
    United KingdomBritish4425080001
    STOKES, Pauline Vera
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane Torton
    DY10 4HX Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish126405790001
    STOKES, Richard William
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane, Torton
    DY104HX Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Yew Tree Cottage
    Torton Lane, Torton
    DY104HX Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish22813550003

    ¿Tiene CENTRAL WEIGHING LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 24 ago 2007
    Entregado el 30 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 17 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 may 1990Registro de una carga
    • 01 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 mar 1986
    Entregado el 09 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000
    Breve descripción
    All the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • W. H. Davies
    Transacciones
    • 09 abr 1986Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 25 abr 1985
    Entregado el 02 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 may 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0