BIOME TECHNOLOGIES PLC
Visión general
Nombre de la empresa | BIOME TECHNOLOGIES PLC |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
Número de empresa | 01873702 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BIOME TECHNOLOGIES PLC?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Dirección de la sede social | Starpol Technology Centre North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Hampshire England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
STANELCO PLC | 16 ago 1991 | 16 ago 1991 |
MERCHANT MANUFACTORY ESTATE COMPANY PLC | 14 may 1985 | 14 may 1985 |
MICROSTONE PUBLIC LIMITED COMPANY | 20 dic 1984 | 20 dic 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 09 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 018737020005, creada el 17 dic 2024 | 45 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Francis Standen como director el 03 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Brian Samuel Geary como director el 25 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Notification de Martin Rushton Turner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||||||||||
Notification de Brian Samuel Geary en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 21 oct 2024 | 2 páginas | PSC09 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 06 sept 2024
| 5 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 06 sept 2024
| 5 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 018737020003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 018737020004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 ago 2024
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 ago 2024
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Edward Herrick como director el 10 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 88 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert St John Smith como director el 29 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga 018737020004, creada el 11 mar 2024 | 51 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 88 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Martin Rushton Turner como director el 25 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 jun 2023
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Starpol Technology Centre Starpol Technology Centre North Road, Marchwood Industrial Park Southampton Hampshire SO40 4BL United Kingdom a Starpol Technology Centre North Road Marchwood Industrial Park Southampton Hampshire SO40 4BL el 13 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPSON-STRANGE, Donna | Secretario | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | British | Solicitor | 135452570002 | |||||
GEARY, Brian Samuel | Director | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | England | British | Director | 328444920001 | ||||
MINES, Paul Robert | Director | Starpol Technology Centre North Road SO40 4BL Marchwood, Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 61345130002 | ||||
RUSHTON TURNER, John Martin | Director | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | England | British | Director | 169441090001 | ||||
DUGGAN, Robert Edward | Secretario | 44 Hillfield Road PO20 0LF Selsey West Sussex | British | Accountant | 88524770001 | |||||
HOZIER, Barrie Clifford | Secretario | Whiteoaks Danesbury Park Warren Park Road SG14 3HX Bengeo Hertfordshire | British | 6915830002 | ||||||
LOVEGROVE, Philip Albert | Secretario | 50 Thorley Lane Bishops Stortford CM23 4AD Hertfordshire | British | 35568310001 | ||||||
WARNER, Clive Howard | Secretario | 5 Hankins Lane NW7 3AA Mill Hill London | British | Finance Director | 82654830001 | |||||
ADAMS, John Gilbert | Director | Princel House Princel Lane Dedham CO7 6HD Colchester Essex | British | Company Director | 74730090001 | |||||
BALCHIN, Ian Henry | Director | Grovelands 22 Station Road OX10 9PT Cholsey Oxfordshire | England | British | Director | 122493020001 | ||||
BOARDMAN, Robert Philip | Director | 81 Mysore Road SW11 5RZ London | United Kingdom | British | Accountant | 77296310002 | ||||
BROWN, Declan Linsay | Director | Starpol Technology Centre North Road SO40 4BL Marchwood, Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 148576850001 | ||||
BROWN, Declan Linsay | Director | Starpol Technology Centre North Road SO40 4BL Marchwood, Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 148576850001 | ||||
BYGRAVE, Sue | Director | The Mill SG14 2SB Hertingfordbury 2 Hertfordshire England | United Kingdom | British | Group Finance Director | 135472100001 | ||||
CAUNT, Ian Charles | Director | 29 Westbury Lodge Close HA5 3FG Pinner Middlesex | British | Chartered Accountant | 800300001 | |||||
DAVIS, Ian Nigel | Director | Oliver House 27 East Barnet Road EN4 8RN New Barnet Hertfordshire | British | Company Director | 1730400001 | |||||
DUGGAN, Robert Edward | Director | 44 Hillfield Road PO20 0LF Selsey West Sussex | British | Accountant | 88524770001 | |||||
FILKIN, Elizabeth Jill | Director | Well Cottage, 15 Albion Street, Shaldon TQ14 0DF Teignmouth Devon | British | Director | 94255650002 | |||||
HERRICK, Simon Edward | Director | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | England | British | Non-Executive Director | 70414940003 | ||||
HOZIER, Barrie Clifford | Director | Whiteoaks Danesbury Park Warren Park Road SG14 3HX Bengeo Hertfordshire | British | Director | 6915830002 | |||||
KAYSER, Michael Arthur | Director | Starpol Technology Centre North Road SO40 4BL Marchwood, Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Director | 141893610001 | ||||
LOVEGROVE, Philip Albert | Director | 177 Pixmore Way SG6 1QT Letchworth Hertfordshire | England | British | Corporate Finance | 35568310007 | ||||
LOVEGROVE, Philip Albert | Director | 50 Thorley Lane Bishops Stortford CM23 4AD Hertfordshire | British | Investment Manager | 35568310001 | |||||
MILLS, Christopher Harwood Bernard | Director | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | United Kingdom | British | Company Director | 35557050001 | ||||
MINES, Paul Robert | Director | Aspen Lodge St Michaels Chase Copford CO6 1EF Colchester | United Kingdom | British | Chief Executive | 61345130001 | ||||
ROBINS, Terry | Director | 20 Gaskyns Close Rudgwick RH12 3HE Horsham West Sussex | British | Packaging Consultant | 109427150001 | |||||
SHEPHERD, Audrey Rose | Director | 69 Brownhill Road Chandlers Ford SO53 2FJ Eastleigh Hampshire | British | Company Director | 16217120001 | |||||
SMITH, Robert St John | Director | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | England | British | Chief Financial Officer | 117976210004 | ||||
STANDEN, John Francis | Director | 17 Ropemakers Fields Narrow Street E14 8BX London | England | British | Executive | 35194870003 | ||||
WAGNER, Martin Joseph | Director | Hope Cottage West End, Seaton Ross YO42 4NN York Yorkshire | British | Commercial Business Management | 109393860001 | |||||
WARNER, Clive Howard | Director | 5 Hankins Lane NW7 3AA Mill Hill London | England | British | Finance Director | 82654830001 | ||||
WHITCHURCH, Graham John | Director | Triangle West End DN17 4RX Garthorpe North Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 87133920002 | ||||
WHITE, Howard | Director | 1 Court View Swains Lane N6 6HA London | British | Company Director | 84493750003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Brian Samuel Geary | 21 ago 2024 | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Martin Rushton Turner | 21 ago 2024 | North Road Marchwood Industrial Park SO40 4BL Southampton Starpol Technology Centre Hampshire England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BIOME TECHNOLOGIES PLC?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
25 abr 2017 | 21 ago 2024 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene BIOME TECHNOLOGIES PLC alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 17 dic 2024 Entregado el 20 dic 2024 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 11 mar 2024 Entregado el 14 mar 2024 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 31 mar 2023 Entregado el 03 abr 2023 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 18 dic 1986 Entregado el 07 ene 1987 | Satisfecho en su totalidad | ||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 26 sept 1986 Entregado el 10 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £250,000 and all other moneys due or to become due from microsstone limited to the chargee pursuant to a loan agreement dated 18/9/86 | |
Breve descripción The entire beneficial shareholding of merchant manufactory estates company PLC in microsstone limited (for full details see doc). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0