WICKES NOMINEE LIMITED

WICKES NOMINEE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWICKES NOMINEE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01874380
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WICKES NOMINEE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WICKES NOMINEE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WICKES NOMINEE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WICKES UK HOLDINGS LIMITED16 dic 198516 dic 1985
    WICKES INVESTMENTS LIMITED07 feb 198507 feb 1985
    SHINEFORE LIMITED27 dic 198427 dic 1984

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WICKES NOMINEE LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2015
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2016
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WICKES NOMINEE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cambio de datos del director Miss Deborah Grimason el 13 oct 2016

    2 páginasCH01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG a 45 Church Street Birmingham B3 2RT el 06 ene 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 dic 2015

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 dic 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 oct 2015

    Estado de capital el 22 oct 2015

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Nombramiento de Miss Deborah Grimason como director el 10 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony David Buffin como director el 10 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Peter Carter como director el 10 sept 2015

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2014 au 30 jun 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 nov 2014

    Estado de capital el 04 nov 2014

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Stephen Pike como secretario el 23 sept 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Tp Directors Ltd como director el 19 sept 2014

    2 páginasAP02

    Resoluciones

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Anthony David Buffin como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 nov 2013

    Estado de capital el 04 nov 2013

    • Capital: GBP 335,012
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Hampden Smith como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de WICKES NOMINEE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRIMASON, Deborah
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Director
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    EnglandBritish185755960002
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Director
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BATTERSBY, Geoffrey Brian
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    Director
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    British41548740003
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Director
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish178011680001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Director
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Director
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    GRIMSEY, William
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Director
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    United KingdomBritish50647840002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HORNE, Nicholas Paul Stewart
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    Director
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    British983490001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    LLEWELLYN, Trefor Wilmot
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish107250730001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Director
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Director
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    STRADLING, Stuart Rhys
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    Director
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    United KingdomBritish44265550001
    SWEETBAUM, Henry Alan
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    Director
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    United KingdomAmerican10349960001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    ¿Tiene WICKES NOMINEE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A mezzanine debenture
    Creado el 28 jul 2003
    Entregado el 13 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transacciones
    • 13 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Senior security accession deed
    Creado el 29 ene 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Creado el 29 ene 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Creado el 16 ene 2001
    Entregado el 31 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V.,London Branch
    Transacciones
    • 31 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 2000
    Entregado el 09 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 09 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed between wickes nominee limited, the parent (as defined) and ing bank N.V. london branch (being supplemental to a debenture dated 26TH september 2000)
    Creado el 27 oct 2000
    Entregado el 06 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) (or any of them)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transacciones
    • 06 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 07 ene 1997
    Entregado el 15 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Creado el 12 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and all or any of the o f the companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 03 jul 1996
    Entregado el 10 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WICKES NOMINEE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 dic 2015Inicio de la liquidación
    09 may 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0