NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01878843 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | City Bridge House 57 Southwark Street SE1 1RU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RELIANCE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 03 mar 2008 | 03 mar 2008 |
| RELIANCE INTEGRATED SERVICES LIMITED | 23 sept 1999 | 23 sept 1999 |
| RELIANCE SECURITY SHREDDING LIMITED | 16 ene 1992 | 16 ene 1992 |
| SECURITY SHREDDING LIMITED | 16 may 1985 | 16 may 1985 |
| PRECIS (361) LIMITED | 18 ene 1985 | 18 ene 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2015 au 31 dic 2014 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed reliance facilities management LIMITED\certificate issued on 10/10/13 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Estado de capital el 09 ago 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2013 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cambio de datos del director Paul James Saville-King el 16 may 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Roberts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Duncan James Green el 07 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Rachel Anne Lee como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH, Daphne Valerie | Secretario | Southwark Street SE1 1RU London City Bridge House 57 | British | 168360670001 | ||||||
| GREEN, Duncan James | Director | Southwark Street SE1 1RU London City Bridge House 57 | England | British | 78619880002 | |||||
| LEE, Rachel Anne | Director | Southwark Street SE1 1RU London City Bridge House 57 | England | British | 168479310001 | |||||
| SAVILLE-KING, Paul James | Director | Southwark Street SE1 1RU London City Bridge House 57 | England | British | 168479060002 | |||||
| FRENCH, Neil Peter Donaldson, Dr | Secretario | Oakleaves 5 Barrington Park Gardens HP8 4SS Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | 166551820001 | ||||||
| MACDONALD, Iain Graham Ross | Secretario | 172 White Hill HP5 1AZ Chesham Buckinghamshire | British | 66669510002 | ||||||
| MASTERS, Raymond James | Secretario | Westbury House Westbury BA5 1HA Wells Somerset | British | 27253600002 | ||||||
| PINTO, Jose Caetano Elias | Secretario | 197 Ramillies Road DA15 9JE Sidcup Kent | British | 1254190001 | ||||||
| SIMON, Jeremy Paul | Secretario | Buckingham Palace Road SW1W 9SA London 130-132 United Kingdom | English | 80286120003 | ||||||
| ADCOCK, Christopher John | Director | 84 Arbor Lane Winnersh RG41 5JD Wokingham Berkshire | England | British | 75526650001 | |||||
| CLARKE, Paul Thomas | Director | The Briars Marriotts Avenue, South Heath HP16 9QL Great Missenden Buckinghamshire | British | 72295570002 | ||||||
| COOPER, Peter Howard | Director | Mallards Foxley Drive CM23 2EB Bishops Stortford Herts | British | 82518430001 | ||||||
| CRILLY, Paul | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex England | Scotland | British | 303840650001 | |||||
| DAVIES, Stephen John | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex England | England | British | 121924830001 | |||||
| DEES, David Bernard | Director | 33 Lethbridge Park Bishops Lydeard TA4 3QU Taunton Somerset | British | 10866530001 | ||||||
| DIAMOND, Malcolm Mcdonald | Director | Diamond Cottage Five Ash Down TN22 3AJ Uckfield East Sussex | England | British | 12095390001 | |||||
| EWEN, David | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex England | British | 140672890001 | ||||||
| FIFIELD, Louisa Mary | Director | 309d Trinity Road Wandsworth Common SW18 3SN London | British | 107396130001 | ||||||
| FISHER, Peter Roy Steven | Director | The Downs Austenwood Lane SL9 9DA Chalfont St. Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 123054670001 | |||||
| FORD, Peter John | Director | 16 The Drive SW20 8TG London | British | 101905640001 | ||||||
| FRASER, Ian Robert | Director | 57 Popes Grove Strawberry Hill TW1 4JZ Twickenham Middlesex | British | 28474370001 | ||||||
| GLENNISTER, Keith | Director | 67 Bennetts Way Shirley CR0 8AF Croydon Surrey | England | British | 39319750001 | |||||
| GORMAN, John Murray | Director | 61 Yew Tree Road Southborough TN4 0BG Tunbridge Wells Kent | British | 48008590001 | ||||||
| HALDER, Graeme Robert | Director | 74 High Street Hardingstone NN4 6DA Northampton | Hong Kong, China | British | 154739000001 | |||||
| JEMSON, Richard Parker | Director | 168 Boldmere Road B73 5UD Sutton Coldfield West Midlands | British | 66752000001 | ||||||
| JONES, Peter Raymond, Dr | Director | 3 Redbourne Drive CW2 5GH Weston Cheshire | England | British | 180049010001 | |||||
| KING, John David | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 41669650001 | |||||
| KINGHAM, Brian Anthony | Director | 31 Carlyle Square SW3 6HA London | England | British | 34220130001 | |||||
| MASTERS, Raymond James | Director | Westbury House Westbury BA5 1HA Wells Somerset | United Kingdom | British | 27253600002 | |||||
| MASTERS, Raymond James | Director | Westbury House Westbury BA5 1HA Wells Somerset | United Kingdom | British | 27253600002 | |||||
| MORTIMER, William Alec | Director | 72a London Road BR1 3QZ Bromley Kent | British | 83291270001 | ||||||
| MURRAY, David Eugene | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex England | British | 59571280004 | ||||||
| NEALON, Barry Montague | Director | 150 Hampton Road West TW13 6BE Feltham Surety House Middlesex England | England | British | 46163020001 | |||||
| NICHOLLS, Julian Frederick | Director | The Thatched Cottage Smiths End Lane Barley SG8 8LH Royston Hertfordshire | England | British | 95086050001 | |||||
| PAICE, Peter John | Director | Flat 4a 59 Harrington Gardens SW7 4JZ London | United Kingdom | British | 122398300001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cbre Managed Services Limited | 06 abr 2016 | Southwark Street SE1 1RU London 57 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene NORLAND INTEGRATED SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture accession deed | Creado el 29 oct 2007 Entregado el 06 nov 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0