OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED

OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOPEN CHAMPIONSHIP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01879216
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RIVERLANE LIMITED21 ene 198521 ene 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Jonathan Timmis como director el 03 mar 2021

    1 páginasTM01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Christine Anne-Marie Logan como secretario el 08 jun 2020

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 103-105 Bath Road Slough Berkshire SL1 3UH a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS el 07 ene 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 19 dic 2019

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Jonathan Timmis el 17 ene 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Jonathan Timmis el 30 jun 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Jonathan Timmis como director el 13 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Candida Jane Davies como director el 13 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Patrick Norris Clements como director el 30 abr 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Richard Mark Greensmith como director el 21 abr 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Richard Mordan como director el 01 oct 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GREENSMITH, Richard Mark
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Director
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    United KingdomBritishGroup Tax Director205672130001
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    Secretario
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    British108679560001
    GOULD, John Roger Beresford
    4 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    Secretario
    4 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    British14374320001
    JOWETT, Jonathan David
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Secretario
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    BritishDirector103825760001
    LOGAN, Christine Anne-Marie
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Secretario
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    193547110001
    MANNION, Antony Clive Patrick
    Castle Farm
    TN32 5JU Mountfield
    East Sussex
    Secretario
    Castle Farm
    TN32 5JU Mountfield
    East Sussex
    BritishCorporate Financier100717090002
    RICHARDSON, Elizabeth Anne
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United Kingdom
    British155632880001
    ANDERSEN, Henning Lang
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United KingdomBritishSvp Financial Planning171037300001
    BUCHAN, Brian John
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishChief Executive75146390001
    BUXTON-SMITH, Maria Rita, Dr
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    Director
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    BritishCompany Secretary132247000001
    CAIZZONE, Salvatore
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United KingdomItalianExecutive Vice President162392060001
    CATER, Iain Charles Douglas
    The Orchard The Avenue
    Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    Director
    The Orchard The Avenue
    Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector14374310003
    CLEMENTS, Patrick Norris, Dr
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United KingdomBritishSvp Fiscal Services178833710001
    DAVIES, Candida Jane
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United KingdomBritishSvp Corporate Controller171034990001
    DAVIS, Shaun Kevin
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    Director
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    Gb-EngUnited KingdomDirector34817680002
    DAWAR, Manish
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    United KingdomIndianAccountant139802400002
    EDWARDS, Simon Jeremy
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    United KingdomBritishSvp Fiscal Services66138060002
    GEORGE, Dieno
    Holsworthy Farm Boots Green
    Allostock
    WA16 9NU Knutsford
    Cheshire
    Director
    Holsworthy Farm Boots Green
    Allostock
    WA16 9NU Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director78647320003
    GOULD, John Roger Beresford
    4 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    Director
    4 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector14374320001
    HUMPHREYS, Roger Owen
    Squirrels Chase 23 Park Road
    Disley
    SK12 2NA Stockport
    Cheshire
    Director
    Squirrels Chase 23 Park Road
    Disley
    SK12 2NA Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director17695720002
    JOWETT, Jonathan David
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Director
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Secretary103825760001
    KEELEY, Martin Spencer
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishAccountant136190480001
    MANNION, Antony Clive Patrick
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    Director
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    United KingdomBritishCorporate Financier100717090003
    MORAN, Mark
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    England
    Director
    35 New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    Ssl International Plc
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director60066000007
    MORDAN, William Richard
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    Berkshire
    England
    United KingdomAmericanLawyer155492700001
    RABBITT, Michael Francis
    50 Verity Street
    East Bierley
    BD4 6PN Bradford
    West Yorkshire
    Director
    50 Verity Street
    East Bierley
    BD4 6PN Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomIrishDirector75918590001
    SANDERS, Paul Antony
    3 Roseneath
    Sandringham Park
    SK7 3LP Bramhall
    Cheshire
    Director
    3 Roseneath
    Sandringham Park
    SK7 3LP Bramhall
    Cheshire
    BritishDirector55533560002
    SLATER, Andrew
    Orwell Dene
    Levington Road
    IP10 0EJ Nacton
    Suffolk
    Director
    Orwell Dene
    Levington Road
    IP10 0EJ Nacton
    Suffolk
    BritishDirector76826750001
    STOLLER, Norman Kelvin
    Inarush Garsdale Lane
    Lostock
    BL1 5XW Bolton
    Lancashire
    Director
    Inarush Garsdale Lane
    Lostock
    BL1 5XW Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17191380002
    TIMMIS, Jonathan
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Director
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    EnglandBritishFinance Director241371800005
    WATTS, Garry
    New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    35
    Director
    New Bridge Street
    EC4V 6BW London
    35
    United KingdomBritishChartered Accountant74863000002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sonet Investments Limited
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    England
    06 abr 2016
    Bath Road
    SL1 3UH Slough
    103-105
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro03012223
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guaratee & debenture
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 11 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or sondico international limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 may 1989Registro de una carga
    • 05 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 mar 1989
    Entregado el 31 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1989Registro de una carga
    • 09 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 21 ene 1988
    Entregado el 27 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ene 1988Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 05 nov 1986
    Entregado el 18 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of floating charge all stocks (as defined in the mortgage debenture) now or at any time during the continvence of the security belonging to and in the physical possesion or contrat of the company.
    Personas con derecho
    • Plenum Financial & Investment Limited
    Transacciones
    • 18 nov 1986Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 07 abr 1986
    Entregado el 11 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Plenum Financial & Investment Limited
    Transacciones
    • 11 abr 1986Registro de una carga
    Further guarantee & debenture
    Creado el 22 abr 1985
    Entregado el 22 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 abr 1985Registro de una carga

    ¿Tiene OPEN CHAMPIONSHIP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 dic 2019Inicio de la liquidación
    29 mar 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0