ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED

ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaORCHARD HOUSE FOODS LIMITED
    Estado de la empresaEn administración
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01897751
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    • Elaboración de jugos de frutas y hortalizas (10320) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FRESH FRUIT JUICE MANUFACTURING LIMITED21 mar 198521 mar 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2022
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta20 jul 2023
    Próxima declaración de confirmación vence03 ago 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta20 jul 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Informe de progreso del administrador

    29 páginasAM10

    Domicilio social registrado cambiado de 11th Floor, Landmark St Peter's Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB a C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB el 20 may 2025

    3 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    4 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    37 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    34 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    4 páginasAM19

    Aviso de orden de destitución del administrador de la oficina

    10 páginasAM16

    Aviso de nombramiento de un administrador suplente o adicional

    3 páginasAM11

    Informe de progreso del administrador

    36 páginasAM10

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    4 páginasAM06

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA/AM02SOC

    17 páginasAM02

    Declaración de la propuesta del administrador

    51 páginasAM03

    Nombramiento de un administrador

    páginasAM01

    Domicilio social registrado cambiado de 79 Manton Road Earlstrees Industrial Estate Corby NN17 4JL England a 11th Floor, Landmark St Peter's Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB el 27 ene 2023

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    4 páginasAM01

    Registro de la carga 018977510019, creada el 21 oct 2022

    42 páginasMR01

    Registro de la carga 018977510018, creada el 29 sept 2022

    24 páginasMR01

    Registro de la carga 018977510017, creada el 23 sept 2022

    42 páginasMR01

    Registro de la carga 018977510016, creada el 25 ago 2022

    38 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021

    33 páginasAA

    Registro de la carga 018977510015, creada el 30 mar 2022

    34 páginasMR01

    Estado de capital el 31 mar 2022

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    ¿Quiénes son los directivos de ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CORBY, Steve
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    Director
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    EnglandBritish290077180001
    DARBY, Gavin John
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    Director
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    EnglandBritish99277850001
    DUCKER, Andrew James
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    Director
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    EnglandBritish140698250001
    SUTCLIFFE, Rebecca Jade
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    Director
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp
    Manchester
    EnglandBritish293026300001
    ADAMS, Douglas Raymond Forsyth
    Grange Farm Cottage
    HP3 0LB Bovingdon Green
    Herts
    Secretario
    Grange Farm Cottage
    HP3 0LB Bovingdon Green
    Herts
    British14862390001
    BRADBURY, Debra
    The Derbyshire Main Street
    Thistleton
    LE15 7RE Oakham
    Rutland
    Secretario
    The Derbyshire Main Street
    Thistleton
    LE15 7RE Oakham
    Rutland
    British72879990001
    DAVENPORT, Michael Christopher
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Secretario
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    British393470002
    DAVENPORT, Michael Christopher
    Sunnydene
    NN6 9QL Walgrave
    Northamptonshire
    Secretario
    Sunnydene
    NN6 9QL Walgrave
    Northamptonshire
    British393470001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    KEEN, Nick
    Killingbeck Drive
    LS14 6UF Leeds
    4
    England
    Secretario
    Killingbeck Drive
    LS14 6UF Leeds
    4
    England
    203723200001
    LANE, Mark John
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Secretario
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    British151306070001
    MUSGROVE, William Davis
    3 Burrows Close
    Welton
    NN11 5EJ Daventry
    Northamptonshire
    Secretario
    3 Burrows Close
    Welton
    NN11 5EJ Daventry
    Northamptonshire
    British393450002
    O'CONNOR, Philip Stephen
    7 The Poplars
    SL5 9HZ South Ascot
    Berkshire
    Secretario
    7 The Poplars
    SL5 9HZ South Ascot
    Berkshire
    Irish107745290001
    STARLEY, John Keith
    Moonrakers Back Lane
    Birdingbury
    CV23 8EN Rugby
    Warwickshire
    Secretario
    Moonrakers Back Lane
    Birdingbury
    CV23 8EN Rugby
    Warwickshire
    British22454090001
    ADAMS, Douglas Raymond Forsyth
    Grange Farm Cottage
    HP3 0LB Bovingdon Green
    Herts
    Director
    Grange Farm Cottage
    HP3 0LB Bovingdon Green
    Herts
    British14862390001
    BRADBURY, Mark Stephen
    6 Wallfields Close
    Findern
    DE65 6QL Derby
    Derbyshire
    Director
    6 Wallfields Close
    Findern
    DE65 6QL Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish43212520001
    CARR, Howard Radley
    8 Market Place
    NG34 0SF Folkingham
    Lincolnshire
    Director
    8 Market Place
    NG34 0SF Folkingham
    Lincolnshire
    British68268990003
    CHARLES, Gavin
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    Director
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish120029860002
    COCKERILL, Michael Alan
    Horsell Lodge Barrowden Road
    Ketton
    PE9 3RJ Stamford
    Lincolnshire
    Director
    Horsell Lodge Barrowden Road
    Ketton
    PE9 3RJ Stamford
    Lincolnshire
    British23733620002
    CONTE, Pasquale
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    UsaUs178915980001
    CUNNINGHAM, Stephen John
    11 Medinah Close
    NN4 0YS Northampton
    Northamptonshire
    Director
    11 Medinah Close
    NN4 0YS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish64703130001
    DAVENPORT, Michael Christopher
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Director
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    British393470002
    FALTISCHEK, Denise Menikheim
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    United StatesAmerican178917830001
    GOLDENITSCH, Wolfgang, Dr
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    AustriaAustrian273996560001
    HAYES, Maurice Alan
    31 Willoughby Drive
    Empingham
    LE15 8PY Oakham
    Leicestershire
    Director
    31 Willoughby Drive
    Empingham
    LE15 8PY Oakham
    Leicestershire
    Irish67511340001
    IDROVO, Javier H
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    United StatesAmerican265407720001
    JACK, David
    14 Clifton Drive
    PE8 4EP Oundle
    Peterborough
    Director
    14 Clifton Drive
    PE8 4EP Oundle
    Peterborough
    EnglandBritish85210160001
    KING, Andrew Saulez
    Bethany 7 Church Lane
    Long Clawson
    LE14 4ND Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    Bethany 7 Church Lane
    Long Clawson
    LE14 4ND Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritish60749420003
    LANE, Mark John
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    EnglandBritish132183700002
    LANGROCK, James Michael
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    United StatesAmerican235110160001
    LONG, David James
    Orchard House West End
    Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Orchard House West End
    Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    British14862400001
    MAGEE, Gerard Vincent
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    Director
    Manton Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JL Corby
    79
    England
    IrelandIrish151272980001
    MARRIOTT, Raymond John, Professor
    The Hollies 69 Gipsy Lane
    NN16 8TZ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    The Hollies 69 Gipsy Lane
    NN16 8TZ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish49559100001
    MORIZZO, Antonio
    11 Chaucer Place
    St Neots
    PE19 7LN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    11 Chaucer Place
    St Neots
    PE19 7LN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British116647880001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hamilton Terrace
    CV32 4LY Leamington Spa
    36
    England
    13 ene 2021
    Hamilton Terrace
    CV32 4LY Leamington Spa
    36
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro12963652
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Century Way, Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    England
    06 abr 2016
    Century Way, Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    England
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05830980
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 ene 2023Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Philip Stephenson
    11th Floor, Landmark St Peter'S Square, 1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    Profesional
    11th Floor, Landmark St Peter'S Square, 1 Oxford Street
    M1 4PB Manchester
    Sarah O'Toole
    11th Floor Landmark St Peters Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Profesional
    11th Floor Landmark St Peters Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Kevin James Coates
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Jonathan Roden
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Profesional
    17th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0