MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01901744 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Oxford Point 19 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LINK PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED | 03 jul 2023 | 03 jul 2023 |
| HS PENSIONS LIMITED | 03 may 2022 | 03 may 2022 |
| HS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | 04 nov 2010 | 04 nov 2010 |
| AEGON TRUSTEE SOLUTIONS LIMITED | 31 dic 2009 | 31 dic 2009 |
| H. S. ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | 18 jul 1985 | 18 jul 1985 |
| PASTCLASS LIMITED | 02 abr 1985 | 02 abr 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2025 au 31 dic 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Modification des détails de Mufg Retirement Solutions Pension Administration Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 may 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Oxford Point 13-17 Oxford Road Bournemouth BH8 8GS United Kingdom a Oxford Point 19 Oxford Road Bournemouth BH8 8GS el 08 may 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard James Wilson como director el 23 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deidre Michelle Mcgrath como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Link Group Corporate Director Limited el 20 ene 2025 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Link Pension Administration Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 ene 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed link pension administration (hs) LIMITED\certificate issued on 20/01/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 019017440004, creada el 28 nov 2024 | 25 páginas | MR01 | ||||||||||
Modification des détails de Link Pension Administration Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del director Link Group Corporate Director Limited el 30 sept 2024 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England a Oxford Point 13-17 Oxford Road Bournemouth BH8 8GS el 30 sept 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Mark Hickling como director el 19 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed hs pensions LIMITED\certificate issued on 03/07/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2022 au 30 jun 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graham Mark Hickling el 31 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Link Group Corporate Director Limited como director el 01 nov 2022 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Simon Pattison como director el 31 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel John Joselyn como director el 31 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Michael Goddard como director el 31 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULLETT, Alexander Eben Ronald | Director | 19 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point England | England | British | 261027470001 | |||||||||
| MUFG PMS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square United Kingdom |
| 239773600009 | ||||||||||
| ALEXANDER, Aileen Lesley | Secretario | 11 The Glebe PH2 9GF Abernethy Perthshire | British | 112583930001 | ||||||||||
| ELSTON, David Aiken | Secretario | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | British | 152119670001 | ||||||||||
| JOHNS, Janet Wilson | Secretario | 45 Daniell Way CH3 5XH Chester Cheshire | British | 9333010001 | ||||||||||
| MACKENZIE, James Kenneth | Secretario | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | British | 155175590001 | ||||||||||
| YOUNG, Ian Gordon | Secretario | 30 Lennox Row EH5 3LT Edinburgh Midlothian | British | 15401360002 | ||||||||||
| ADAMSON, Mark Henzell | Director | 12 Alma Road Clifton BS8 2BY Bristol | British | 98758680001 | ||||||||||
| BEATTIE, John Colin | Director | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | Scotland | British | 136508990001 | |||||||||
| BLACKMAN, Andrew John | Director | Tudor Close CR2 9DX South Croydon 22 Surrey | England | British | 117751660001 | |||||||||
| BLACKMUR, Paul Anthony | Director | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | 291426250001 | |||||||||
| BRUNET, Maurice Clive | Director | 12 Abbots Walk KY2 5NL Kirkcaldy Fife | United Kingdom | British | 62153230002 | |||||||||
| CHADWICK, Robert | Director | 20 Tarvin Road Littleton CH3 7DG Chester Cheshire | England | British | 119286210001 | |||||||||
| CONNOR, Stephen | Director | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | 57576050002 | |||||||||
| COONEY, Cathryn Anne | Director | Amberlea Mold Road Wylfa Hill Mynydd Isa CH7 6TD Mold Flintshire | British | 63745990003 | ||||||||||
| DORNAN, Peter Gordon | Director | 2 Hopetoun Park EH31 2EP Gullane East Lothian | Scotland | British | 77337710001 | |||||||||
| GODDARD, Steven Michael | Director | High Street TN13 1JD Sevenoaks The Old Vicarage Kent | England | British | 71681800001 | |||||||||
| GRACE, Adrian Thomas | Director | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | 125518930001 | |||||||||
| HICKLING, Graham Mark | Director | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | 156117950003 | |||||||||
| HICKLING, Graham Mark | Director | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon 8th Floor Corinthian House Surrey | England | British | 138276550001 | |||||||||
| HORN, Iain George | Director | 99 Beamish Close Appleton WA4 5RJ Warrington | British | 81285160002 | ||||||||||
| JONES, Peter | Director | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | 278135940001 | |||||||||
| JOSELYN, Daniel John | Director | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | 298246750001 | |||||||||
| MACKLE, Feilim | Director | 11 Marine Parade EH39 4LD North Berwick East Lothian | Scotland | Irish | 164413100001 | |||||||||
| MCGRATH, Deidre Michelle | Director | 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | Australia | Australian | 301828790001 | |||||||||
| PATTISON, Mark Simon | Director | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | 264174130001 | |||||||||
| QUINLIVAN, John | Director | 26 Woodside Park Avenue Walthamstow E17 3NP London | British American | 77511360001 | ||||||||||
| ROBERTSON, William John | Director | 4 Cavendish Drive Newton Mearns G77 5NY Glasgow | Scotland | British | 145428580001 | |||||||||
| SCOTT, Gillian Catherine | Director | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | 124638490001 | |||||||||
| SMITH, Ronald | Director | St Michaels Golly Burton Rossett LL12 0AH Wrexham Clwyd | British | 5826110001 | ||||||||||
| STEVENSON, Nina Clare | Director | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House Surrey | United Kingdom | British | 196362910001 | |||||||||
| STEWARD, John Timothy Hugh | Director | The Farthings Well Lane CH3 8AU Mouldsworth Cheshire | England | British | 9333020001 | |||||||||
| STEWARD, Margaret Beatrice | Director | The Farthings Well Lane CH3 8AU Mouldsworth Cheshire | England | British | 9333030001 | |||||||||
| THORESEN, Otto | Director | Westerlea Abbotsford Road EH39 5DB North Berwick East Lothian | Scotland | British | 45163250002 | |||||||||
| WALLER, Robert Thomas | Director | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | 138112660001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mufg Retirement Solutions Pension Administration Limited | 31 oct 2022 | 19 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Goddard Perry Holdings Limited | 07 sept 2020 | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House Surrey England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Goddard Perry Consulting Limited | 06 abr 2016 | Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0