HPM & ADDO LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHPM & ADDO LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01906031
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HPM & ADDO LTD?

    • otras impresiones (18129) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra HPM & ADDO LTD?

    Dirección de la sede social
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HPM & ADDO LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HILLPRINT MEDIA LIMITED21 oct 200321 oct 2003
    HILLPRINT LIMITED10 ene 198910 ene 1989
    THOMAS HILL PRINT (1985) LIMITED10 sept 198510 sept 1985
    FERDOM LIMITED17 abr 198517 abr 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HPM & ADDO LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HPM & ADDO LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Nombramiento de un administrador

    páginas2.12B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 27 ene 2016

    21 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 30 oct 2015

    21 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de 9th Floor Bond Court Leeds LS1 2JZ a Fourth Floor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ el 26 oct 2015

    2 páginasAD01

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 30 abr 2015

    19 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    30 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Prime House Park 2000 Heighington Lane Business Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6AR a 9Th Floor Bond Court Leeds LS1 2JZ el 15 dic 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cancelación total de la carga 019060310010

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 019060310009

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2014

    Estado de capital el 23 oct 2014

    • Capital: GBP 79,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Richard Thomas Mortimer como secretario el 30 sept 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Thomas Mortimer como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jul 2014

    Estado de capital el 23 jul 2014

    • Capital: GBP 79,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Keiran John Bayley como director el 31 may 2014

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Richard Thomas Mortimer el 31 may 2014

    2 páginasCH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed hillprint media LIMITED\certificate issued on 16/06/14
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name16 jun 2014

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 16 jun 2014

    RES15
    change-of-name16 jun 2014

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2013

    10 páginasAA

    Registro de la carga 019060310010

    7 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Richard Lister como director

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 019060310009

    7 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 04 jul 2013

    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de HPM & ADDO LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAYLEY, Keiran John
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Fourth Floor Toronto Square
    Director
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Fourth Floor Toronto Square
    EnglandBritish181397910002
    CONNELL, Valerie
    Eden Road
    DL5 5QY Newton Aycliffe
    29
    Co Durham
    Secretario
    Eden Road
    DL5 5QY Newton Aycliffe
    29
    Co Durham
    British137583350001
    GROVES, Peter
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    Secretario
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    British37554590001
    JACKSON, Terence George
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    Secretario
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    British74363830001
    MORTIMER, Richard Thomas
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Secretario
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    171064410001
    ANTHONY, John Newsam
    Delegate Cottage
    Fellside
    NE46 1RB Hexham
    Northumberland
    Director
    Delegate Cottage
    Fellside
    NE46 1RB Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish37840020002
    CONNELL, Valerie
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish154038790001
    DRENNAN, Margaret
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    British62255560002
    DRENNAN, Margaret
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    British62255560002
    GREEN, Peter
    37 The Vale
    Elm Tree Farm
    TS19 0XL Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    37 The Vale
    Elm Tree Farm
    TS19 0XL Stockton On Tees
    Cleveland
    EnglandBritish49133370001
    GROVES, Peter
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    Director
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    United KingdomBritish37554590001
    JACKSON, Terence George
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    Director
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    British74363830001
    LISTER, Richard Lyle
    38 Russell Street
    Waterhouses
    DH7 9AR Durham
    County Durham
    Director
    38 Russell Street
    Waterhouses
    DH7 9AR Durham
    County Durham
    EnglandBritish122586320001
    METCALFE, Caroline Mary
    315 Durham Road
    NE9 5AH Gateshead
    Tyne & Wear
    Director
    315 Durham Road
    NE9 5AH Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish63638760001
    MORTIMER, Richard Thomas
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish12349090001
    SMITH, Ian Paul
    The Ldoge
    The Stables
    PH4 4GD West Herrington
    Sunderland
    Director
    The Ldoge
    The Stables
    PH4 4GD West Herrington
    Sunderland
    British62255580002
    TAYLOR, Antony John
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish22432000001
    VASS, Christopher Gareth
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    United KingdomBritish14263320001

    ¿Tiene HPM & ADDO LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2013
    Entregado el 23 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    2004 heidelberg CD74-5 + l-c five colour offset printing press with coating unit serial no. 450705. all the company’s present or future indebtedness to city business finance LTD whether solely or jointly with any other person or persons and whether as principle or surety or actually or contingently, together with any other costs, charges and legal expenses (on a full indemnity basis) charged or incurred by city business finance LTD; including those arising from city business finance LTD perfecting or enforcing or attempting to enforce the said charge or any other security (and it’s rights thereunder) held by city business finance LTD from time to time. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • City Business Finance LTD T/a Print Finance
    Transacciones
    • 23 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 29 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 06 dic 2013
    Entregado el 06 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    2001 muller martini presto saddle stitcher s/N.NN9452 Z0508690, apollo compensating stacker s/N.NN26099, 2004 heidelberg stahl RFH66 th/kh folder s/N.fh.habo.00259, 2004 heidelberg polar 92X guillotine s/N.7411215, 2002 heidelberg polar 115E s/N.7231426, 1981 heidelberg gto-52 press s/N.675427, 2001 norpak 2001 polyprocessor s/N.0006038.. All the company’s present or future indebtedness to city business finance LTD whether solely or jointly with any other person or persons and whether as principle or surety or actually or contingently, together with any other costs, charges and legal expenses (on a full indemnity basis) charged or incurred by city business finance LTD; including those arising from city business finance LTD perfecting or enforcing or attempting to enforce the said charge or any other security (and it’s rights thereunder) held by city business finance LTD from time to time.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • City Business Finance LTD T/a Print Finance
    Transacciones
    • 06 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 29 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 12 abr 2012
    Entregado el 14 abr 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £38,500 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Asset make - norpak model - 2001 polyprocessor chassis/serial number registration number - 0902062. asset make - polar- 2MODEL - guilotine model 92X chassis/serial number registration number - 7417215.
    Personas con derecho
    • Trustees of Hillprint LTD Directors Pension Scheme
    Transacciones
    • 14 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    Chattel mortgage
    Creado el 04 jul 2008
    Entregado el 19 jul 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Muller martini presto saddle stitcher equipped with four compact feeders type 1551 folder feeder 1528 and belt delivery behind trimmer machine serial no KA508690.
    Personas con derecho
    • Richard Thomas Mortimer Peter Groves Margaret Drennan and North East Trustees Limited in Their Capacity as Trustees of Hillprint Limited Directors Pension Scheme
    Transacciones
    • 19 jul 2008Registro de un cargo (395)
    All assets debenture
    Creado el 27 jun 2008
    Entregado el 02 jul 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 02 jul 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 28 oct 1999
    Entregado el 02 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transacciones
    • 02 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge
    Creado el 16 jun 1998
    Entregado el 20 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase agreement numbered 70/216/ils/17055652-2
    Breve descripción
    First fixed charge over heidelberg mo press with print unit serial no 602031, muller martini 1509 saddle stitching line 6 stations 3 feeders type 1516 1522 trimmer & box delivery no;-99 20668 0853 stahl automatic folding machine T52-f/t 46782 199049 stahl folding machine T52-f 36999 157144 and polar mohr 115 guillotine 4531 443.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 20 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 07 abr 1986
    Entregado el 17 abr 1986
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold & l/hold property, bldgs and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery, bookdebts, goodwill uncalled capital undertakings and assets and all the property described in the schedule attached to doc M14 (see for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1986Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 07 abr 1986
    Entregado el 09 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £36,750.
    Breve descripción
    Land and buildings at cockton hill bishop auckland durham.
    Personas con derecho
    • The County Council of Durham
    Transacciones
    • 09 abr 1986Registro de una carga
    • 22 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 abr 1986
    Entregado el 25 may 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £41,215.25
    Breve descripción
    F/Hold printing works at cockton hill bishop auckland co. Durham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Thos. Hill Print Limited
    Transacciones
    • 25 may 1986Registro de una carga
    • 26 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HPM & ADDO LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 oct 2014Inicio de la administración
    27 ene 2016Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Lee Van Lockwood
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Profesional
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Profesional
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0