TULLETT PREBON (UK) LIMITED

TULLETT PREBON (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTULLETT PREBON (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01908771
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    • Administración de mercados financieros (66110) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    135 Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PREBON MARSHALL YAMANE (UK) LIMITED01 jun 199901 jun 1999
    PREBON YAMANE (UK) LIMITED31 jul 199231 jul 1992
    BABCOCK FULTON PREBON LIMITED10 abr 199010 abr 1990
    BABCOCK & BROWN (KW) LIMITED15 jun 198915 jun 1989
    BABCOCK & BROWN (MONEY MARKET) LIMITED16 jul 198616 jul 1986
    MONEY MARKET AGENCIES LIMITED16 ene 198616 ene 1986
    PRECIS (456) LIMITED26 abr 198526 abr 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 dic 2021

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 24 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 30 oct 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2020 au 30 dic 2020

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ England a 135 Bishopsgate London EC2M 3TP el 07 may 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    1 páginasAA

    Estado de capital el 04 dic 2020

    • Capital: GBP 0.10
    3 páginasSH19

    Declaración de confirmación presentada el 30 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 22/04/2020
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    26 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de confirmación presentada el 29 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Andrew Ren-Yiing Chen como director el 23 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul James Ashley como director el 27 sept 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    1 páginasAA

    Modification des détails de Prebon Yamane International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2018

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Tower 42 Level 37 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ a Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ el 31 dic 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    1 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Robin James Stewart el 17 jul 2018

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHEN, Andrew Ren-Yiing
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish225251990001
    STEWART, Robin James
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BRILL, Tiffany Fern
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Secretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    218151560001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Secretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Secretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    DYER BARTLETT, Diana
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    177123560001
    HOSKINS, Justin Wilbert
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    171912470001
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Secretario
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British812670009
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Secretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    British90844500002
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Secretario
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalCOMPANIES ACT 2006
    Número de registroOC309455
    131429630001
    ASHLEY, Paul James
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    EnglandBritish332150410001
    BATEMAN, Richard Harrison
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    Director
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    British1478010001
    BOLTON, Marcus Peregrine
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    Director
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    EnglandBritish84102400001
    BRIGHT, Steven Lee
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    Director
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    British104678480001
    BUIK, David Barlow
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Director
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Canadian2294590001
    BURNETT, Michael Arthur
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Director
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    British32574310001
    CALVERT, John Michael
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    Director
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    British68355150001
    COMPAS, Felix George
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    Director
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    British32574320002
    CORKER, Stephen Roger
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    Director
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    United KingdomBritish43964780001
    COSTELLO, Kevin
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    Director
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    British32574330002
    DAWES, Cindy Jane
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    Director
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom74822120001
    DUCKWORTH, Stephen Charles
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish69519860001
    DUNKLEY, Paul Simon
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Director
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish138694990001
    GARTHWAITE, Ian Dudley
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    Director
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    British32034890001
    GIORDANO, Anthony
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Director
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    British32574350001
    GOLDBERG, David Howard
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    Director
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    British67412280001
    GRANAT, Ian James
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    Director
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    British104761410001
    HARNETT, Geoffrey Victor
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    Director
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    British56333090001
    HAWKINS, James Patrick Fitzgerald
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    Director
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    British32574370001
    HEATH, Jeremy Richard
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish32574380001
    HOCKEY, Joseph Max
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    Director
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    British78982470001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Prebon Yamane International Limited
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    06 abr 2016
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House (England And Wales)
    Número de registro2619854
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TULLETT PREBON (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental security agreement
    Creado el 12 ene 2009
    Entregado el 15 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme (The Trustees)
    Transacciones
    • 15 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental security agreement
    Creado el 12 ene 2009
    Entregado el 15 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (the Trustees)
    Transacciones
    • 15 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of novation and amendment
    Creado el 15 nov 2007
    Entregado el 20 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from tullet prebon group limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge all its assets on the terms of the security agreement as amended by the deed,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (Trustees)
    Transacciones
    • 20 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security agreement
    Creado el 29 ene 2007
    Entregado el 16 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the principal employer not exceeding £12,500,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first floating charge all assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme
    Transacciones
    • 16 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security agreement
    Creado el 29 ene 2007
    Entregado el 13 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the principal employer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme
    Transacciones
    • 13 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Terms of business agreement
    Creado el 06 mar 2001
    Entregado el 27 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descripción
    By way of first, fixed charge and pledge over all securities, documents of or entering title to property, cash or other assets of any nature held by or subject to the control of fcl by way of deposit or margin (or any nominee or custodian of fcl) for the account of the client (including without limitation, the benefit of all contractual rights and obligations and any proceeds of sale and any securities or other assets which fcl has agreed to hold as custodian) and by way of general lien and right of set-off.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Clearing London Limited
    Transacciones
    • 27 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 ene 1986
    Entregado el 20 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. (See doc no M17).
    Personas con derecho
    • Aidamoor Limited
    Transacciones
    • 20 ene 1986Registro de una carga

    ¿Tiene TULLETT PREBON (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 dic 2021Inicio de la liquidación
    14 mar 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0