CCL LINDAB LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCCL LINDAB LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01909033
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CCL LINDAB LIMITED?

    • Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y equipos y suministros de calefacción (46740) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra CCL LINDAB LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Units 9-10 Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CCL LINDAB LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CCL VELODUCT LIMITED16 feb 200116 feb 2001
    CONTRACT COMPONENTS LIMITED05 jun 198505 jun 1985
    DICEMEWS LIMITED29 abr 198529 abr 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CCL LINDAB LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CCL LINDAB LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Jonas Fredrik Liedholm como director el 30 jun 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Ola Henrik Gosta Ranstam como director el 30 jun 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael John Goodspeed como director el 20 jun 2019

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Jonas Fredrik Lidholm el 26 jul 2018

    3 páginasCH01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 sept 2015

    Estado de capital el 21 sept 2015

    • Capital: GBP 1,075,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Carl-Gustav Nilsson como director el 01 sept 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonas Fredrik Lidholm como director el 01 sept 2014

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 sept 2014

    Estado de capital el 30 sept 2014

    • Capital: GBP 1,075,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 oct 2013

    Estado de capital el 15 oct 2013

    • Capital: GBP 1,075,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Nombramiento de Financial Controller Robert Evans como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mika Repo como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de CCL LINDAB LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EVANS, Robert, Financial Controller
    Units 9-10 Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    Secretario
    Units 9-10 Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    168606250001
    RANSTAM, Ola Henrik Gosta
    Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    Units 9-10
    United Kingdom
    Director
    Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    Units 9-10
    United Kingdom
    SwedenSwedishGroup Legal Councel260047340001
    KIMBER, Malcolm Richard
    4 Ailsworth Road
    LU3 2UG Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    4 Ailsworth Road
    LU3 2UG Luton
    Bedfordshire
    British20834960002
    PENNYCUICK, Andrew Leslie
    4 Hartland Avenue
    MK40 3BD Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    4 Hartland Avenue
    MK40 3BD Bedford
    Bedfordshire
    British966850001
    REPO, Mika Rikhard
    Units 9-10 Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    Secretario
    Units 9-10 Carousel Way
    Riverside Business Park
    NN3 9HG Northampton
    156237160001
    REVIN, Anders
    32 Valentine Way
    Great Billing
    NN3 9XD Northampton
    32
    Northamptonshire
    Uk
    Secretario
    32 Valentine Way
    Great Billing
    NN3 9XD Northampton
    32
    Northamptonshire
    Uk
    SwedishFinancial Controller134271370001
    ROBERTS, David John
    24 Eastmont Road
    Hinchley Wood
    KT10 9AZ Esher
    Surrey
    Secretario
    24 Eastmont Road
    Hinchley Wood
    KT10 9AZ Esher
    Surrey
    BritishChartered Accountant20817130002
    ADAIR, Robert Fredrik Martin
    Cowesby Hall
    Cowesby
    YO7 2JJ Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    Cowesby Hall
    Cowesby
    YO7 2JJ Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinancier37096760007
    AHLVIN, Freddie, Vice President
    Svardlangsvagen 17a
    Arsta
    Se-120 60
    Sweden
    Director
    Svardlangsvagen 17a
    Arsta
    Se-120 60
    Sweden
    SwedishBu Devel. Director74885520002
    BARHAM, Richard William
    Lodge Paddocks
    Warings Green Road, Hockley Heath
    B94 6BT Solihull
    West Midlands
    Director
    Lodge Paddocks
    Warings Green Road, Hockley Heath
    B94 6BT Solihull
    West Midlands
    BritishInternal Audit Manager79278350001
    BARKER, David Grant
    Wealden Fen Pond Road
    Ightham
    TN15 9JE Sevenoaks
    Kent
    Director
    Wealden Fen Pond Road
    Ightham
    TN15 9JE Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director15130700001
    CONNOLLY, Michael Arthur
    5 Faversham Road
    Owlsmoor
    GU15 4YP Camberley
    Surrey
    Director
    5 Faversham Road
    Owlsmoor
    GU15 4YP Camberley
    Surrey
    BritishAccountant15573420001
    GOODSPEED, Michael John
    1 Walnut Gardens
    Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    Director
    1 Walnut Gardens
    Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManaging Director113475500001
    GOODSPEED, Michael John
    1 Walnut Gardens
    Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    Director
    1 Walnut Gardens
    Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishSales Director113475500001
    KIMBER, Malcolm Richard
    4 Ailsworth Road
    LU3 2UG Luton
    Bedfordshire
    Director
    4 Ailsworth Road
    LU3 2UG Luton
    Bedfordshire
    BritishProduct Manager20834960002
    LEE, Geoffrey Michael
    Adelaide Cottage
    Common Road
    LU6 2NQ Studham
    Bedfordshire
    Director
    Adelaide Cottage
    Common Road
    LU6 2NQ Studham
    Bedfordshire
    BritishCompany Director117962850001
    LIEDHOLM, Jonas Fredrik
    c/o Lindab Ab
    Jarnvagsgatan
    269 82 Baastad
    41
    Sweden
    Director
    c/o Lindab Ab
    Jarnvagsgatan
    269 82 Baastad
    41
    Sweden
    SwedenSwedishCompany Director193590360002
    NEWMAN, Brian Morley
    Beckbury House
    87 London Road
    SY2 6PQ Shrewsbury
    Salop
    Director
    Beckbury House
    87 London Road
    SY2 6PQ Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritishChartered Engineer15143700001
    NILSSON, Carl-Gustav
    Kaptensgatan 5
    Viken
    Se 26040
    Sweden
    Director
    Kaptensgatan 5
    Viken
    Se 26040
    Sweden
    SwedenSwedishLegal Counsel90429920001
    ROBERTS, David John
    24 Eastmont Road
    Hinchley Wood
    KT10 9AZ Esher
    Surrey
    Director
    24 Eastmont Road
    Hinchley Wood
    KT10 9AZ Esher
    Surrey
    BritishChartered Accountant20817130002
    ROBERTSON, Iain Thomas
    3 Dumpers Drive
    Horton Heath
    SO50 7DP Eastleigh
    Director
    3 Dumpers Drive
    Horton Heath
    SO50 7DP Eastleigh
    EnglandBritishSales Director127430300001
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector1604580001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CCL LINDAB LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Lindab International Ab
    Jarnvagsgatan
    Grevie
    41
    Sweden
    24 ago 2016
    Jarnvagsgatan
    Grevie
    41
    Sweden
    No
    Forma jurídicaPlc
    País de registroSweden
    Autoridad legalSweden
    Lugar de registroStockholm
    Número de registro556606-5446
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CCL LINDAB LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 feb 2000
    Entregado el 03 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 08 feb 2000
    Entregado el 09 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Chattels 1 x 1999 spiro automatic tubeformer 1602 no 1510 inc run off table please refer to form 395.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 09 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 30 jun 1999
    Entregado el 06 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £84,352.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    1 x used spiro automatic tubeformer model 1613C jrx. Serial no. 1401JRX including: decoiler, run off table serial no: 152954, flying slitter with knives serial no 151877 plus 2 x form roll units and 20 x forming heads.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 30 oct 1998
    Entregado el 10 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £95,265 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    1 x used spiro automatic tubeformer 1613CJ rx no 831613, 1 x used spiro run-off table no 152954 and other chattels as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 26 jul 1993
    Entregado el 05 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due the comapny to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property being or k/a unit 27 stirchley trading estate birmingham and the proceeds of sale thereof together with the assigns the goodwill of the business and full benefit of all licences and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 jul 1993
    Entregado el 22 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 jul 1993
    Entregado el 23 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-10 woodall road redburn industrial estate enfield middlesex and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 jun 1993
    Entregado el 06 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-unit 20 guinness road trading estate trafford park manchester and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 oct 1989
    Entregado el 07 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See 395 ref M190 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • T S B Bank PLC
    Transacciones
    • 07 nov 1989Registro de una carga
    • 18 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 07 oct 1988
    Entregado el 13 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Other debts. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • T S B England and Wales PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1988Registro de una carga
    • 25 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 21 sept 1987
    Entregado el 28 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ductwork components (doby) limited to the chargee on any account whatsever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1987Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0