LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01909337 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Dirección de la sede social | 3rd Floor One New Change EC4M 9AF London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
RETAIL PARKS LIMITED | 29 sept 1986 | 29 sept 1986 |
TEXAS WAREHOUSE SALES LIMITED | 14 may 1985 | 14 may 1985 |
PHONASTYLE LIMITED | 29 abr 1985 | 29 abr 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 04 nov 2020 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||
Segunda presentación de un estado de capital tras una asignación de acciones el 09 sept 2020
| 4 páginas | RP04SH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 nov 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 sept 2020
| 4 páginas | SH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cese del nombramiento de Sonja Arsenić como secretario el 21 nov 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||
Nombramiento de Ladbrokes Coral Corporatr Secretaries Limited como secretario el 21 nov 2019 | 2 páginas | AP04 | ||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Sonja Arsenić como secretario el 08 ago 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||
Cese del nombramiento de Ladbrokes Coral Corporate Secretaries Limited como secretario el 08 ago 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Modification des détails de Ladbroke Group Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jul 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||
Cambio de datos del secretario Ladbrokes Coral Corporate Secretaries Limited el 10 jul 2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5th Floor the Zig Zag Building 70 Victoria Street London England SW1E 6SQ England a 3rd Floor One New Change London EC4M 9AF el 17 jul 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||
Cese del nombramiento de Cassandra Alice Cammidge como director el 28 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Modification des détails de Ladbroke Group Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jun 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Cassandra Alice Cammidge como director el 16 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Keith Howard Mason como director el 16 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Nombramiento de Charles Alexander Sutters como director el 12 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Vinod Parmar como director el 12 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADBROKES CORAL CORPORATR SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor England |
| 264854400001 | ||||||||||
SMITH, Stuart John | Director | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 224533160001 | ||||||||
SUTTERS, Charles Alexander | Director | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | England | British | Company Director | 221886390001 | ||||||||
ARSENIĆ, Sonja | Secretario | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | 261328120001 | |||||||||||
HUGHES, Barbara | Secretario | Flat 3 11 Hazelmere Road NW6 6PY London | British | 45702460001 | ||||||||||
NOBLE, Michael Jeremy | Secretario | Rectory Lodge Parsons Shaw Lusted Hall Lane TN16 2NL Tatsfield Kent | British | 32786810002 | ||||||||||
LADBROKES CORAL CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | 60530770047 | |||||||||||
ADAMS, David Alexander Robertson | Director | 58 Dry Hill Park Road TN10 3BX Tonbridge Kent | British | Accountant | 55757700002 | |||||||||
ADELMAN, Jonathan Mark | Director | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | England | British | Company Secretary | 84639590002 | ||||||||
ANDERSON, Randolph John | Director | 43 Duckett Road N4 1BJ London | British | Company Director | 65745670001 | |||||||||
BARKER, Pamela Joy | Director | 13 The Paddocks Stapleford Abbotts RM4 1HG Romford Essex | British | Chartered Accountant | 115289630001 | |||||||||
BATY, John Clifford | Director | Flat C 1 Cranley Gardens N10 3AA London | England | British | Group Financial Controller | 100331850001 | ||||||||
BOYDELL, Joanna | Director | Boreas Rushmere Lane HP5 3QY Chesham Buckinghamshire | England | British | Accountant | 118883430001 | ||||||||
BUSHNELL, Adrian John | Director | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Company Secretary | 210900670001 | ||||||||
CAMMIDGE, Cassandra Alice, Cassandra'S Company Secretarial Services | Director | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | England | British | Chartered Secretary | 245446520001 | ||||||||
COLEMAN, John | Director | Belchers Farm Belchers Lane Nazeing EN9 2SA Waltham Abbey Essex | British | Company Director | 56366250001 | |||||||||
DYSON, Ian | Director | The Laurels Miles Lane KT11 2ED Cobham Surrey | British | Accountant | 50916710001 | |||||||||
EARP, Neil Timothy | Director | Springfield Farm Warren Lane SG9 9QD Cottered Hertfordshire | British | Chartered Surveyor | 83045240001 | |||||||||
FRANKS, Nigel Alan | Director | 18 Gilkes Crescent SE21 7BS London | United Kingdom | British | Company Director | 119727210001 | ||||||||
GOSLING, Peter Charles | Director | 95 Worcester Road SM2 6QL Cheam Surrey | England | English | Company Director | 142633640001 | ||||||||
HIBBERT, Stephen | Director | Manor House Dockenfield GU10 4HL Farnham Surrey | British | Company Director | 37097410001 | |||||||||
HUMPHREYS, Stephen | Director | 1 Victoria Yard Fairclough Street E1 1PP London | British | Director | 71438830002 | |||||||||
JONES, Nigel Richard Ifor | Director | 14 Wootton Hill Farm East Hunsbury NN4 9JJ Northampton | British | Financial Controller | 69526300001 | |||||||||
LENNARD, Geoffrey | Director | Flat 11 Laurie House 16 Airlie Gardens W8 7AW London | British | Commercial Manager | 27565120002 | |||||||||
LEWIS, Steven David | Director | 66 Sheringham Avenue N14 4UG London | British | Sales And Marketing Executive | 32315950001 | |||||||||
MASON, Geoffrey Keith Howard | Director | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 37404250003 | ||||||||
MORGAN, Nicholas Mark | Director | 55 Dukes Wood Drive SL9 7LJ Gerrard's Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | Financial Director | 106335450001 | ||||||||
NOBLE, Michael Jeremy | Director | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32786810005 | ||||||||
O'MAHONY, Jeremiah Francis | Director | Jerpoint House 11 Grange Court Road East Common AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | Company Director | 1128630001 | |||||||||
PARMAR, Vinod | Director | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | United Kingdom | British | Treasurer | 124202750001 | ||||||||
SHAH, Snehal | Director | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 167628520002 | ||||||||
STEIN, Cyril | Director | Flat 60 Hyde Park Towers Porchester Terrace W2 3HJ London | British | Company Director | 40629810001 | |||||||||
STEWART, Donald Gordon William | Director | Arntemplar 69 Main Street Killearn G63 9NE Glasgow | British | Development Director | 39839930001 | |||||||||
TALJAARD, Desmond Louis Mildmay | Director | 59 Crescent West EN4 0EQ Hadley Wood Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 215884620001 | ||||||||
TRENTER, Ronald Charles | Director | The Lodge Warren Lane SG9 9QS Cottered Buntingford | British | Director | 92995260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladbroke Group Properties Limited | 06 abr 2016 | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor England United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Creado el 06 nov 1989 Entregado el 24 nov 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of missives dated 6TH and 7TH june 1989 amended by formal letters dated 29/9/89 | |
Breve descripción All and whole that plot or area of ground in the county of ay[r which is situate generally to the west of those houses and others as be on the western side of mcinway crescent, irvine (for full details see form 395). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Development agreement | Creado el 23 dic 1987 Entregado el 13 ene 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land at county oak adjoining london road crawley west sussex t/n wsx 113440. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0