CLIFFMERE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLIFFMERE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01912852 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLIFFMERE LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CLIFFMERE LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLIFFMERE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLIFFMERE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de John Daniel Sheehan como director el 27 feb 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Patrick Bradley como director el 27 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ronald Matthew Defeo como director el 11 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin Patrick Bradley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Phillip Widman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * C/O Denton Wilde Sapte Llp the Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE United Kingdom* el 03 ago 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jul 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ronald Matthew Defeo el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 252 Upper Third Street Grafton Gate East Central Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1DZ* el 06 ago 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLIFFMERE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHEN, Eric I | Secretario | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | American | 65582430009 | ||||||
| COHEN, Eric I | Director | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | United States | American | 65582430009 | |||||
| SHEEHAN, John Daniel | Director | 200 Nyala Farm Road 06880 Westport C/O Terex Corporation Usa | United States | American | 226001330001 | |||||
| BROOKES, Howard Maurice | Secretario | 14 Ryknild Close Four Oaks B74 4UP Sutton Coldfield West Midlands | British | 662930001 | ||||||
| HARRIS, Andrew David | Secretario | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| APUZZO, Joseph | Director | 190 Sturges Ridge Road Wilton Fairfield 06897 Usa | American | 66269020001 | ||||||
| BAILLIE, Fergus Cumming | Director | 4 Abinger Gardens Murrayfield EH12 6DE Edinburgh Scotland | British | 924340002 | ||||||
| BRADLEY, Kevin Patrick | Director | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | Untied States Of America | American | 176590390001 | |||||
| CAMPBELL, Donald | Director | 6 Gleannan Park BT79 7XZ Omagh County Tyrone N.Ireland | Irish | 68499570001 | ||||||
| CRAIG, John Egwin | Director | Saxonbury House Frant TN3 9HJ Tunbridge Wells Kent | British | 15697900001 | ||||||
| DEFEO, Ronald Matthew | Director | Beachside Avenue Westport 45 Connecticut 06880 Usa | United States | American | 94656950001 | |||||
| DOOEY, Hugh Pat | Director | 14 Usnastraine Road BT71 5DE Coalisland Tyrone N Ireland | Northern Ireland | Irish | 115095900001 | |||||
| HARRIS, Andrew David | Director | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| KENNERLEY, John Frank William | Director | Old Westwick Chantry View Road GU1 3XW Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69793560001 | |||||
| O'SULLIVAN, Kerry | Director | 920 Burr Street Fairfield Connecticut Usa | American | 70733110001 | ||||||
| WATSON, Hubert John | Director | 20 Victoria Grove Dollingstown Lurgan BT66 7JJ Craigavon County Armagh | British | 56996050003 | ||||||
| WIDMAN, Phillip Charles | Director | 25 Old Stone Crossing West Simsbury Connecticut 06092 Usa | Usa | American | 144249950001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLIFFMERE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerscreen International Limited | 06 abr 2016 | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLIFFMERE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 25 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 25 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 25 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 25 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 04 mar 1999 Entregado el 25 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0