ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01917732
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    West Point
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAYVERN LIMITED27 jul 198727 jul 1987
    HAYVERN CONSTRUCTION LIMITED30 may 198530 may 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2013
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2014
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 jun 2016

    11 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 jun 2015

    9 páginas4.68

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX a West Point Old Trafford Manchester M16 9HU el 18 jul 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 jun 2014

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Eastwood como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Birch como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Nelson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Melvyn Ewell como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 feb 2014

    Estado de capital el 11 feb 2014

    • Capital: GBP 441,001
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2012

    12 páginasAA

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Sherard Secretariat Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Paul Birch como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David Foster como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Melvyn Ewell como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew Latham Nelson como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Fraser como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Arnold como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de John Flood como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secretario corporativo
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Director
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritishDirector76116640003
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Director
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritishDirector160883820001
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretario
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Secretario
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    British27826460002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    BritishSolicitor36153790001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director181213200001
    ATHERTON, Paul Taylor
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    Director
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    United KingdomBritishBuilder82322300001
    BILLINGTON, David
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    Director
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    BritishBuilder27826470001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Director
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritishCommercial Manager116126370001
    COLLINS, John
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    Director
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    BritishSales & Marketing Director95036480001
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Director
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant27826460002
    DUNN, Lorraine
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Director
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    BritishSecretary27826490001
    DUNN, Philip
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Director
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    BritishBuilder27826480001
    ENTWISTLE, Keith Roy
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    Director
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    BritishChartered Surveyor51587490001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritishCeo61515760002
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector73695830003
    FOSTER, David Neil
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79227590003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUkChief Executive28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Director
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Director
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector72254420003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Director
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    LAVERY, Kevin Gregory
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    Director
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    United KingdomBritishDirector115961810003
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Director
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    IrishChief Operating Officer96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Director
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    Director
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritishFinance Director36191090003
    NEWSOME, William
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    Director
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    BritishDirector84941580001
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Director
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Director
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    BritishDirector25364820002
    PARKER, Gary
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director50372730001
    ROULSTONE, Graham Frank
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    Director
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    EnglandBritishIt Director112257690001

    ¿Tiene ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Creado el 01 nov 2001
    Entregado el 02 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transacciones
    • 02 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage
    Creado el 06 mar 2000
    Entregado el 08 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises at queen street/ gas street farnworth bolton greater manchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Commercial property security deed
    Creado el 05 may 1999
    Entregado el 12 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H- queen street,farnworth,bolton and land and buildings on the west side of gas street farnworth bolton greater manchester.t/nos GM686096 and GM265102.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge deed
    Creado el 10 jul 1990
    Entregado el 19 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The performance of the companies obligations to robert heyworth group limited under the agreement dated 28/6/90 and in the charge deed.
    Breve descripción
    The sum of fifty thousand pounds placed on deposit at national westminster bank 46 market street chorley lancs.
    Personas con derecho
    • Robert Heyworth Group Limited
    Transacciones
    • 19 jul 1990Registro de una carga
    • 11 feb 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 12 sept 1988
    Entregado el 15 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Stocks shares other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb England & Wales PLC
    Transacciones
    • 15 sept 1988Registro de una carga
    • 09 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 jun 2014Inicio de la liquidación
    11 ene 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Profesional
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0