COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01917810 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PROPERTY BUREAU LIMITED(THE) | 02 jul 1985 | 02 jul 1985 |
| MARCHDREW LIMITED | 30 may 1985 | 30 may 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 27 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2021 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Joseph Mullen como director el 16 ago 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Richard Fox como director el 16 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Jeremy Ian Fuller como director el 01 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vijay Lakhman Vaghela como director el 01 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director T M Directors Limited el 04 may 2018 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario T M Secretaries Limited el 04 may 2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853180002 | ||||||||||
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Director | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square United Kingdom | England | British | 181763320002 | |||||||||
| MULLEN, James Joseph | Director | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | Scottish | 91567460002 | |||||||||
| REACH DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853130002 | ||||||||||
| APPLETON, David Neil | Secretario | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Secretario | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Secretario | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | British | 146096300001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Secretario | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 | ||||||||||
| AITKEN, Geraldine | Director | 1 Clydesdale Court Kings Lane CV37 0LZ Snitterfield Warwickshire | British | 73882830001 | ||||||||||
| ALLWOOD, Charles John | Director | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | 35681240003 | |||||||||
| APPLETON, David Neil | Director | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| BURTON, Royston Walter | Director | 89 Corbett Road Hollywood B47 5LT Birmingham | British | 44120740001 | ||||||||||
| DAY, Philip Julian | Director | 42 Heath Croft Road B75 6RW Sutton Coldfield West Midlands | British | 14092200001 | ||||||||||
| EWING, Margaret | Director | Maraval Hamm Court KT13 8YG Weybridge Surrey | British | 68009020001 | ||||||||||
| FOX, Simon Richard | Director | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||||||
| HADDOW, Andrew David Charles | Director | 68 Pinewoods Avenue Hagley DY9 0JF Stourbridge West Midlands | British | 54060210001 | ||||||||||
| HUTCHBY, Michael | Director | 26 Sunnyhill LE10 2SB Hinckley Leicestershire | British | 61630410001 | ||||||||||
| KIRBY, Alan Alwyne | Director | 48 Bawnmore Road Bilton CV22 7QW Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 148157770001 | |||||||||
| LESTER, Vernon David Walter | Director | 26 East Mount Road YO2 2BD York North Yorkshire | British | 51985920001 | ||||||||||
| MASON, Daniel Cavner | Director | 72 Church Road Erdington B24 9BD Birmingham | British | 38365090002 | ||||||||||
| OAKLEY, Christopher John | Director | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | 68410390001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Director | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| POWLES, Sharon Susan | Director | Thurleycroft Common Lane, Mappleborough Green B80 7DP Studley Warwickshire | British | 108225810001 | ||||||||||
| VAGHELA, Vijay Kumar Lakhman Meghji | Director | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 60412210002 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Director | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 146096300001 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Director | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | England | British | 146096300001 | |||||||||
| WELLS, Stephen David | Director | 7 Jacksons Meadow Bidford On Avon B50 4HQ Alcester Warwickshire | British | 53321720002 | ||||||||||
| WEST, Denise May | Director | 642 Streetsbrook Road B91 1LB Solihull West Midlands | British | 52930570001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Director | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hinckley Times Limited | 06 abr 2016 | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 16 mar 1990 Entregado el 20 mar 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due to the banks or any of them or standard chartered bank for itself and as agent and trustee for the banks by midland newspapers limited under the facility agreement dated 2/3/90 or by the company pursuant to a guarantee dated 16/3/90 made in favour of the agent or by midland or any guarantor (as defined) under any financing documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (for full details see form 395) see 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0