ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01918522 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Dirección de la sede social | Griffins Suite 011 Unit2 94a Wycliffe Road NN1 5JF Northampton |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FIRST NATIONAL OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED | 30 dic 1998 | 30 dic 1998 |
| LOMBARD OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED | 31 jul 1985 | 31 jul 1985 |
| TRUMPVIEW LIMITED | 03 jun 1985 | 03 jun 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de 2 Triton Square Regents Place London NW1 3AN a Griffins Suite 011 Unit2 94a Wycliffe Road Northampton NN1 5JF el 19 ene 2026 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Triton Square Regent's Place London NW1 3AN a 2 Triton Square Regents Place London NW1 3AN el 06 ene 2026 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Ms Rosamund Martha Rule como director el 17 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nameeta Pai como director el 22 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 32 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen David Affleck como director el 08 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Lee Thomas Grant como director el 08 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen David Affleck como director el 31 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rachel Jane Morrison como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 oct 2021 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Raymond White como director el 23 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom |
| 171739990001 | ||||||||||
| GRANT, Lee Thomas | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 312322560001 | |||||||||
| RULE, Rosamund Martha | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 297165190001 | |||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Secretario | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Secretario | 7 The Adelaide Higham ME3 7LU Rochester Kent | British | 34423910001 | ||||||||||
| STRANAGHAN, Patricia Ann | Secretario | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Triton Square Regents Place NW1 3AN London Abbey National House | 133901580001 | |||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| AFFLECK, Stephen David | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 213797030002 | |||||||||
| COLES, Shaun Patrick | Director | Chaplin Walk Great Cornard CO10 0YT Sudbury 4 Suffolk | United Kingdom | British | 95706540001 | |||||||||
| ELLWOOD, Michael | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 3 | United Kingdom | British | 162422770001 | |||||||||
| GREEN, David Martin | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 157202700001 | |||||||||
| HOCKEY MORLEY, Gary | Director | 69 Westbury Road HA6 3DA Northwood Middlesex | British | 78595520001 | ||||||||||
| HONEY, Andrew Roland | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 151306350001 | |||||||||
| JACKSON, Mark Cunliffe | Director | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | England | British | 96878690002 | |||||||||
| JOHNSON, Jeffrey | Director | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | 103077710001 | ||||||||||
| MABERLY, Michael Alan | Director | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | 1288990001 | ||||||||||
| MORLEY, Anthony Nigel | Director | 24 Wood End Road AL5 3ED Harpenden Hertfordshire | British | 2951350001 | ||||||||||
| MORRISON, Rachel Jane | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 79351960007 | |||||||||
| MURLEY, Timothy Cornelius | Director | Lower Ground Floor Flat 135 Gloucester Avenue Primrose Hill NW1 8LA London | British | 94288090003 | ||||||||||
| PAI, Nameeta | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | Australian | 285803270001 | |||||||||
| PATEL, Shashin | Director | 91 Chester Drive HA2 7PX Harrow Middlesex | England | British | 79860270001 | |||||||||
| ROOME, Harry Mccrea | Director | The Duchies Mill Lane, Pirbright GU24 0BT Woking Surrey | England | British | 64898180001 | |||||||||
| ROUGIER, Alan Toby | Director | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 108954830002 | |||||||||
| SCOTT, John Stearn | Director | Three Elms Common Gate Road WD3 5JR Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 7126810001 | |||||||||
| SMART, James Ramsay | Director | 13 Alexandra Drive MK16 0ES Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 57425040001 | ||||||||||
| STAMPER, Christopher Paul | Director | 11 Cedar Drive Fetcham KT22 9ET Leatherhead Surrey | England | British | 37053220002 | |||||||||
| STEWART, David Howat | Director | 6 Carew Lodge Carew Road HA6 3NH Northwood Middlesex | England | British | 108672850001 | |||||||||
| WHITE, Gavin Raymond | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 202413360001 | |||||||||
| WRIGHT, Jason Leslie | Director | Sandford Lodge 21 Reading Road OX10 9DS Wallingford Oxfordshire | British | 72145280003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Equity Investments Limited | 14 may 2018 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Abbey National Treasury Services Overseas Holdings | 06 abr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Santander Uk Plc | 06 abr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0