KARSONS 2016 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKARSONS 2016 LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 01928109
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KARSONS 2016 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KARSONS 2016 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KARSONS 2016 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KARSONS PHARMACY LIMITED03 jul 198503 jul 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KARSONS 2016 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el11 ene 2019
    Próximas cuentas vencen el11 oct 2019
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KARSONS 2016 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Misceláneos

    Form b to convert to rs
    1 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to rs 28/05/2019
    RES13

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2017

    4 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 23 sept 2016

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 ago 2015

    Estado de capital el 05 ago 2015

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Nombramiento de Cws (No.1) Limited como director el 06 oct 2014

    2 páginasAP02

    Cese del nombramiento de John Branson Nuttall como director el 06 oct 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Anthony Philip James Crossland como director el 06 oct 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anthony John Smith como director el 06 oct 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ago 2014

    Estado de capital el 19 ago 2014

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de KARSONS 2016 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150146440001
    CROSSLAND, Anthony Philip James
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125492370001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director corporativo
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    BritishSecretarial Administrator110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MEASURIA, Daksha
    66 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Secretario
    66 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishCo Secretary31974160001
    MEASURIA, Haresh
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Secretario
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British26898740001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secretario corporativo
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Logistics140380300001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Director
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Executive10084840001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishFinancial Controller49108820004
    CHALMERS, Arthur
    39 Catterick Road
    Didsbury
    M20 6HF Manchester
    Director
    39 Catterick Road
    Didsbury
    M20 6HF Manchester
    BritishChartered Accountant59818810001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Director
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritishHead Of Commercial125645380001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Director
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritishDeputy Chief Executive84868550001
    MEASURIA, Haresh
    66 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Director
    66 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishDirector26898740002
    MEASURIA, Karsanbhai Vithalbhai
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Director
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishDirector26898750001
    MEASURIA, Karsanbhai Vithalbhai
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Director
    201 Mossley Road
    OL6 6LX Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishDirector26898750001
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Health Care Gr44967060002
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Director
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    BritishGeneral Manager Health Care44967060001
    RICHMAN, Jonathan Max
    17 Ravensway
    Prestwich
    M25 0EU Manchester
    Director
    17 Ravensway
    Prestwich
    M25 0EU Manchester
    EnglandBritishPharmacist54694490001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Director
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritishSolicitor182256460001
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director - Healthcare137558680001
    THOMPSON, Christopher Howard Gould
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishGeneral Manager38632440001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Director
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Controller60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Director corporativo
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para KARSONS 2016 LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    31 jul 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene KARSONS 2016 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 22 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 26 reddish road stockport and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 286 gorton road reddish stockport and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 153 block lane chadderton and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 139 droylsden road newton heath manchester and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 35 wellington road south stockport and/or the proceeds of sale and assigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 03 mar 1989
    Entregado el 08 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1989Registro de una carga
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 13 abr 1987
    Entregado el 29 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    64 cornwall street, oldham greater manchester and/or the proceeds of sale thereof title no ol 2065.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 1987Registro de una carga
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 ago 1985
    Entregado el 12 sept 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold 5 alderford parade cheetham greater manchester. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1985Registro de una carga
    • 09 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0