ICE DEVELOPMENTS LIMITED

ICE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaICE DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01933851
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARROWADD LIMITED26 jul 198526 jul 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Latham Nelson el 25 nov 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Paul Birch el 16 ene 2020

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Paul Birch el 16 ene 2020

    1 páginasCH03

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    11 páginasAA

    Modification des détails de Enterprise Holding Company No1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB el 02 sept 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Enterprise Holding Company No1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Latham Nelson como director el 18 dic 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Secretario
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    British76116640002
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Director
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Director
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector36191090004
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    LAWSON, Robert William
    Tookey House Bullock Road
    Haddon
    PE7 3TS Peterborough
    Cambs
    Secretario
    Tookey House Bullock Road
    Haddon
    PE7 3TS Peterborough
    Cambs
    British17838300001
    LAYLEE, Graham Alexander
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    Secretario
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    British20268140002
    LEE, Sandra Dawn
    13 Whernside Way
    Leyland
    PR25 4ZN Preston
    Lancashire
    Secretario
    13 Whernside Way
    Leyland
    PR25 4ZN Preston
    Lancashire
    British74829960001
    WILLIAMS, Neil Edward
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    Secretario
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    British2927950001
    BROCKLEHURST, Charles Richard
    Pond Cottage
    48 Great Hampden
    HP16 9RS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Pond Cottage
    48 Great Hampden
    HP16 9RS Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor39660240001
    DEWHURST, Andrew Paul
    6 Hill Top
    LA7 7RD Milnthorpe
    Cumbria
    Director
    6 Hill Top
    LA7 7RD Milnthorpe
    Cumbria
    BritishChartered Surveyor61272950001
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller160883820001
    FURLONG, Gwynne Patrick
    Triggs Farm Fishwick Lane
    Higher Wheelton
    PR6 8HT Chorley
    Lancs
    Director
    Triggs Farm Fishwick Lane
    Higher Wheelton
    PR6 8HT Chorley
    Lancs
    EnglandBritishChartered Surveyor14172020001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Director
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor61478920003
    HARRABIN, Ian David
    Loft 1 89 Turnmill Street
    EC1M 5QU London
    Director
    Loft 1 89 Turnmill Street
    EC1M 5QU London
    EnglandBritishChartered Surveyor14672310003
    HYNES, Michael Robert
    13 Chapman Road
    Fulwood
    PR2 8NX Preston
    Lancashire
    Director
    13 Chapman Road
    Fulwood
    PR2 8NX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector2927960001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Director
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    LAYLEE, Graham Alexander
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    Director
    19 Calais Street
    SE5 9LP London
    BritishAccountant20268140002
    LOVELL, William Anthony
    Red Cottage Church Cliff
    Kingsdown
    CT14 8AT Deal
    Kent
    Director
    Red Cottage Church Cliff
    Kingsdown
    CT14 8AT Deal
    Kent
    BritishChartered Surveyor18677910001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Director
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Director
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    NORTHEN, Robert Ian
    Rustlemere
    Nyetimber Copse
    RH22 2NE West Chiltington
    West Sussex
    Director
    Rustlemere
    Nyetimber Copse
    RH22 2NE West Chiltington
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor17838320001
    PORTER, Alan Redvers
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    Director
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    BritishChartered Accountant17838310001
    SELLERS, Philip Edward
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director10598350001
    SPERBER, Marcus
    38 Willifield Way
    NW11 7XT London
    Director
    38 Willifield Way
    NW11 7XT London
    BritishChartered Surveyor69147520001
    TAYLOR, David Wilson
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    Director
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive48552500002
    TAYLOR, David Wilson
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    Director
    Chandos House
    Hill Road, Penwortham
    PR1 9XH Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector48552500002
    THOMAS, Wyndham
    8 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    8 Westwood Park Road
    PE3 6JL Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishConsultant17838340001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ICE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06 abr 2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2401383
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ICE DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 21 ago 2000
    Entregado el 23 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries(As Defined) (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2000
    Entregado el 06 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a development agreement dated 24TH december 1999
    Breve descripción
    Land at wisbech road and black bank road littleport cambridgeshire t/no:CB232192.
    Personas con derecho
    • East Cambridgeshire District Council
    Transacciones
    • 06 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 ene 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 30 sept 1999
    Entregado el 08 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays bank PLC re ice developments limited high interest business account number 90499064. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 feb 1999
    Entregado el 11 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies now due or hereafter to become due from time to time accruing due from the company and/or enterprise PLC to the bank upon any account and in any manner whatsoever
    Breve descripción
    Land situate in watson street, middlesbrough, redcar and cleveland title number CE115947.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 feb 1999
    Entregado el 11 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from the company and/or enterprise PLC to the bank upon any account and in any manner whatsoever
    Breve descripción
    Land situate on the east side of hay lane and the south side of bayley lane coventry known as 8,9, 10 & 10A hay lane, west midlands title number wm 550447.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 ene 1997
    Entregado el 22 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The saveker funding as defined in the finance agreement of even date and all liabilities of the company to the chargee under or in respect of the finance agreement,the legal charge and costs and expenses incurred by the fund in enforcing the legal charge
    Breve descripción
    L/Hold land known as land at elkington st,aston,demised by a lease dated 17/1/97 (as defined) and the benefit of all development documents,all insurance policies and rents; fixed charge over recovery of vat,monies placed in development account and company rights in respect of the saveker site.
    Personas con derecho
    • Bri Tel Fund Trustees Limited
    Transacciones
    • 22 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 08 mar 1993
    Entregado el 17 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All sums of money deposited with the bank number 30998222 (see form 395 for details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 24 ago 1992
    Entregado el 03 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details refer to doc M395 ref M193C & continuation sheets).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 jun 1992
    Entregado el 20 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the east side of hay lane and south side of bayley lane together with buildings k/a 8, 9, 10 & 10A hay lane and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 15 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 ene 1992
    Entregado el 24 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    7-57 (odd nos.) seymour street, liverpool and 96-100 (even nos.) london road, liverpool and 2-48 (even nos.) hart street, liverpool, merseyside title no. MS314905.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 abr 1991
    Entregado el 20 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a cleveland business centre at the junction of russell street and watson street, middlesborough, cleveland, and all plant and machinery and other chattles thereon floating charge all unattached plant machinery and other chattels thereon.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 20 abr 1991Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 30 nov 1990
    Entregado el 06 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 1,130,000 due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    Land situate on the east side of hay lane and the south side of bayley lane, coventry containing an area of 1299 sq. Metres approx.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1990Registro de una carga
    • 15 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 oct 1990
    Entregado el 14 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property at city road, east manchester fixed charge over plant and machinery and other chattels, floating charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 14 nov 1990Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 jul 1990
    Entregado el 12 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Two plots of land situate in and fronting to city road east, medlock street, glass street, river street and shortcroft street gaythorne, manchester, containing 0.55 hectares approx.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1990Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 jul 1990
    Entregado el 12 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Standard form jct private with quantities building contract dated 25/5/90 made between john sisk & son (northern) LTD and the company.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Co-Operative Bank PLC.
    Transacciones
    • 12 jul 1990Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 jun 1990
    Entregado el 20 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29/1/90 as varied by a supplemental agreement dated 29/1/90
    Breve descripción
    F/H property k/a coronation buildings, south lambeth road, london SW8. Title no. Tgl 36625.
    Personas con derecho
    • The Mayor and Burgesses of the London Borough of Lambeth
    Transacciones
    • 20 jun 1990Registro de una carga
    • 17 nov 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 abr 1990
    Entregado el 12 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Coronation buildings, south lambeth road, vauxhall, l/b of lambeth part title no. Sgl 43528.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 abr 1990Registro de una carga
    • 15 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 ene 1990
    Entregado el 03 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All rights title & interst of the company in the development being a building agreement a grants agreement a task force agreement & in the land & premises.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1990Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 feb 1989
    Entregado el 08 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land on the south east side of albion street manchester title no gh 456629. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 08 mar 1989Registro de una carga
    Charge
    Creado el 22 feb 1989
    Entregado el 03 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The benefit of a building agreement see doc M513C for details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 ene 1989
    Entregado el 16 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Victoria works, graham st, birmingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Unity Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1989Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 abr 1988
    Entregado el 10 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All estate interest or right whatsoever of the company over the parcel of land having frontages to burley street & stockwell street greenwich london SE10 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personas con derecho
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    Transacciones
    • 10 may 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 09 feb 1988
    Entregado el 19 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The guildhall high street walsall, W.midlands title nos WM395514, wm 378336 WM399321.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 feb 1988Registro de una carga
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 27 oct 1987
    Entregado el 04 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 27-10-87.
    Breve descripción
    Agreement dated 27-10-87 and land at burney street, and shoewell street, greenwich london SE10.
    Personas con derecho
    • Chartered Trust Public Limited Company.
    Transacciones
    • 04 nov 1987Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0