PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01936715 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Level 3, Plant Basing View RG21 4HG Basingstoke Hampshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 ene 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 oct 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2025 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Sibtain Raffiq-Fazal como director el 18 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Wing como director el 18 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Miss Natalie Jayne Spurrier el 21 nov 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Automobile Association Developments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Modification des détails de Automobile Association Developments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mr Sibtain Riffiq-Fazal el 30 abr 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Fanum House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4EA a Level 3, Plant Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4HG el 01 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2024 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Sibtain Riffiq-Fazal como director el 30 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Mary Horrell como director el 30 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kathryn Thomas como director el 03 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Natalie Jayne Spurrier como director el 01 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Audie Daniel Russell como director el 01 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Katherine Mary Horrell como director el 01 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2021 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Gillian Pritchard como director el 10 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Ian Jones como director el 10 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Marianne Neville como director el 10 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL, Audie Daniel | Director | Basing View RG21 4HG Basingstoke Level 3, Plant Hampshire England | United Kingdom | British | 288952490001 | |||||
| SPURRIER, Natalie Jayne | Director | Basing View RG21 4HG Basingstoke Level 3, Plant Hampshire England | England | British | 265687460002 | |||||
| WING, Michael | Director | Basing View RG21 4HG Basingstoke Level 3, Plant Hampshire England | United Kingdom | British | 323683060001 | |||||
| DAVIES, John | Secretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 115843280001 | ||||||
| FLEMING, Catherine Elinor | Secretario | The Old Power House Marlston RG18 9UL Thatcham Berkshire | British | 57034510001 | ||||||
| FREE, Catherine Marie | Secretario | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | 245942170002 | |||||||
| HOOSEN, Nadia | Secretario | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | 255280020001 | |||||||
| MORRILL, Claire | Secretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 183977970001 | |||||||
| NGONDONGA, Taguma | Secretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171627060001 | |||||||
| POMROY, Jennifer Margaret | Secretario | 4 Lynwood Gardens RG27 9DT Hook Hampshire | British | 63371940001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Secretario | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SKEEN, Colin Jeffrey | Secretario | 2 Worcester Crescent BS8 3JA Bristol Avon | Uk | 70313340001 | ||||||
| WOOLF, Paul Antony | Secretario | Freemantle King Lane SO20 8JE Over Wallop Hampshire | British | 160679880001 | ||||||
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | 71532760003 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED | Secretario corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 83911920002 | |||||||
| ALLEN, Tracy Lorraine | Director | 62 Hazel Close Whitton TW2 7NR Twickenham Middlesex | British | 62914950001 | ||||||
| APPLETON, Patricia Anne | Director | 39 Chazey Road Caversham RG4 7DS Reading Berkshire | British | 49658460004 | ||||||
| BARNES, Nicola Helen | Director | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 213971180001 | |||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Director | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| CALDWELL, Lucy Elizabeth | Director | 19 St Davids Drive TW20 0BA Englefield Green Surrey | British | 36551070002 | ||||||
| CANE, Lindsay David | Director | Brooklands Pankridge Street Crondall GU10 5QU Farnham Surrey | British | 49508190001 | ||||||
| GARRIHY, Anne | Director | 38 Bunbury Way KT17 4JP Epsom Surrey | British | 41928680001 | ||||||
| GOODLAD, Louise Clare | Director | Woodcutters Cottage Chapel Road Mortimer West End RG7 3UP Reading Berkshire | British | 46856140003 | ||||||
| HANCOCK, Helen Jane | Director | Broadbent Close Rownhams SO16 8LQ Southampton 16 Hants United Kingdom | United Kingdom | British | 193426410001 | |||||
| HARRISON, Maxine Louise | Director | 28 Cumberland Road Kew TW9 3HQ Richmond Surrey | England | British | 5340190006 | |||||
| HORRELL, Katherine Mary | Director | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 159205280001 | |||||
| HOWARD, Stuart Michael | Director | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| HURST, Lesley Jane | Director | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 183651420001 | |||||
| JONES, Richard Ian | Director | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 250924570001 | |||||
| MILLAR, Mark Falcon | Director | Basing View Basingstoke RG21 4EA Hants Fanum House United Kingdom | England | British | 84701400002 | |||||
| NEVILLE, Marianne | Director | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 235099440002 | |||||
| PARKER, Timothy Charles | Director | Southwood East Apollo Rise GU14 0JW Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | 122029390001 | |||||
| PEARCE, Mark Vivian | Director | 28 Carey Road Moordown BH9 2XB Bournemouth Dorset | British | 26776940001 | ||||||
| POULTER, Melissa Jane | Director | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | United Kingdom | British | 252178770002 | |||||
| PRITCHARD, Gillian Rosemary | Director | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | England | British | 208086500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PERSONAL INSURANCE MORTGAGES AND SAVINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile Association Developments Limited | 06 abr 2016 | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Automobile Association Developments Limited | 06 abr 2016 | Basing View RG21 4HG Basingstoke Level 3, Plant Hampshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0