GAME STORES GROUP LIMITED

GAME STORES GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGAME STORES GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01937170
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GAME STORES GROUP LIMITED?

    • Venta al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados (47540) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra GAME STORES GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GAME STORES GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EB STORES GROUP LIMITED15 jul 199915 jul 1999
    THE ELECTRONICS BOUTIQUE STORES (UK) LIMITED04 ene 199604 ene 1996
    FUTURE ZONE STORES LIMITED12 oct 199212 oct 1992
    RHINO GROUP LIMITED24 sept 199224 sept 1992
    PARKLAN LIMITED02 oct 198502 oct 1985
    LEGIBUS 625 LIMITED08 ago 198508 ago 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GAME STORES GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 ene 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GAME STORES GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GAME STORES GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 07 sept 2015

    13 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 25 sept 2015

    15 páginas2.35B

    Aviso de renuncia de un administrador

    1 páginas2.38B

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Informe de progreso del administrador hasta 07 mar 2015

    16 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 07 sept 2014

    15 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Benjamin White como director el 08 ago 2014

    2 páginasTM01

    Informe de progreso del administrador hasta 07 mar 2014

    16 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 15 feb 2014

    16 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 15 ago 2013

    14 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 15 feb 2013

    15 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Domicilio social registrado cambiado de * Unity House Telford Road Basingstoke Hampshire RG21 6YJ* el 29 oct 2012

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador hasta 25 sept 2012

    16 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Ian Shepherd como director

    2 páginasTM01

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    28 páginasF2.18

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    18 páginas2.16B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    ¿Quiénes son los directivos de GAME STORES GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AXON, Jonathan Mark
    Upper Park Road
    DA17 6EW Upper Belvedere
    22
    Kent
    Director
    Upper Park Road
    DA17 6EW Upper Belvedere
    22
    Kent
    EnglandBritishDirector129328140001
    BLUNDEN, Paul John
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Director
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritishAccountant167658770001
    DEVINE, Thomas Robert
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Director
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritishRegional Managing Director161968010001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Secretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secretario
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British125932650001
    BOYCE, Stephen
    62 Whellock Road
    Chiswick
    W4 1DZ London
    Director
    62 Whellock Road
    Chiswick
    W4 1DZ London
    BritishProperty Director87617670001
    BRENNAN, Patricia
    24 Russell Road
    Horsell
    GU21 4UU Woking
    Surrey
    Director
    24 Russell Road
    Horsell
    GU21 4UU Woking
    Surrey
    EnglandBritishBuying Director108794580001
    CROFT, Alexander Bernard James
    Porthleven House
    19 Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Porthleven House
    19 Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishBuying Director87618090002
    CROWNE, Peter Charles
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    Director
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    United KingdomBritishAccountant106991580002
    CURRAN, Ian
    Flat 10a
    Temple Market Queens Road
    KT13 9DL Weybridge
    Surrey
    Director
    Flat 10a
    Temple Market Queens Road
    KT13 9DL Weybridge
    Surrey
    BritishBuying Director37911860001
    FREY, Colin Lionel
    Top Floor 14 Campden Hill Gardens
    W8 7AY London
    Director
    Top Floor 14 Campden Hill Gardens
    W8 7AY London
    BritishBuying Marketing And Distribut49879190001
    GAWTHORNE, Mark David
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    Director
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant117119930001
    GIBBS, Martyn Ian
    The Avenue
    RG45 6PG Crowthorne
    26
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Avenue
    RG45 6PG Crowthorne
    26
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector129016580002
    HARRIS, Antony Sonny
    137 Britten Close
    NW11 7HW London
    Director
    137 Britten Close
    NW11 7HW London
    BritishI T Director17608740003
    KENT, Richard Graeme
    White Way
    White Way
    DT11 8JA Tarrant Hinton
    Dorset
    Director
    White Way
    White Way
    DT11 8JA Tarrant Hinton
    Dorset
    EnglandBritishDirector70841260004
    KILBY, Alan James
    105 Lynmouth Crescent
    Furzton Lake
    MK4 1JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    105 Lynmouth Crescent
    Furzton Lake
    MK4 1JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director110557200001
    LONG, Martin
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Director
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director125885350001
    MACARIO, Anna Maria
    52 Stoke Road
    KT11 3BJ Cobham
    Surrey
    Director
    52 Stoke Road
    KT11 3BJ Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishMarketing Director87617470001
    MARTEL, Nicholas Rupert
    Flat 1 111 St Georges Square
    SW1V 3QP Pimlico
    London
    Director
    Flat 1 111 St Georges Square
    SW1V 3QP Pimlico
    London
    United KingdomBritishDirector83438690001
    MASON, Stephen
    Huckleberry
    7 South Cliff Avenue
    BN20 7AH Eastbourne
    East Sussex
    Director
    Huckleberry
    7 South Cliff Avenue
    BN20 7AH Eastbourne
    East Sussex
    BritishDirector61288000001
    MCMENEMIE, Carolyn
    106 Glendouglas Drive
    Craigmarloch
    G68 0DW Cumbernauld
    Glasgow
    Director
    106 Glendouglas Drive
    Craigmarloch
    G68 0DW Cumbernauld
    Glasgow
    BritishHuman Resources Director87617830001
    MOLD, Stephen Graham
    61 Chirstchurch Drive
    NN11 4SW Daventry
    Northamptonshire
    Director
    61 Chirstchurch Drive
    NN11 4SW Daventry
    Northamptonshire
    BritishBuying Dir72077760001
    MORGAN, Lisa Jayne
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    Director
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    BritishDirector38420460004
    MURDOCH, Graeme
    277 Chester Road
    Streetly
    B74 3EA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    277 Chester Road
    Streetly
    B74 3EA Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector20816940001
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Director
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director8778080001
    O'CONNELL, Stephen
    Trebrea Studio
    PL34 0HR Trenale
    Cornwall
    Director
    Trebrea Studio
    PL34 0HR Trenale
    Cornwall
    BritishDistribution Director112752510001
    PICKUP, Anthony Robert
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishDirector49762320003
    POOK, Simon Nicholas
    115 Larkvale
    Watermead
    HP19 0YP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    115 Larkvale
    Watermead
    HP19 0YP Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director87617630001
    PRINCE, Paul Edward
    60 Hempstead Road
    ME7 3RF Gillingham
    Kent
    Director
    60 Hempstead Road
    ME7 3RF Gillingham
    Kent
    BritishSales Director108732340001
    QUINN, Robert Francis Gerard
    30 Grayston Manor
    Chryston
    G69 9JW Glasgow
    Director
    30 Grayston Manor
    Chryston
    G69 9JW Glasgow
    BritishSales Director87617910002
    RIPLEY, Beverley
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    Director
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    BritishCompany Director23762560001
    SHAH, Kishorilal
    16 Pines Close
    HA6 3SJ Northwood
    Middlesex
    Director
    16 Pines Close
    HA6 3SJ Northwood
    Middlesex
    British13933810001
    SHEPHERD, Ian
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector153448920001
    SPENCE, Marc George
    Jasmine Bank
    30 Ellesborough Road
    HP22 6EL Wendover
    Buckinghamshire
    Director
    Jasmine Bank
    30 Ellesborough Road
    HP22 6EL Wendover
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director87617720001
    STEINBRECHER, John Mark
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    Director
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    AmericanVice President43688810003

    ¿Tiene GAME STORES GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 01 mar 2011
    Entregado el 15 mar 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The present security by way of equitable mortgage and the new rights existing at 01 march 2011 with respect to the present security see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 15 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 01 mar 2011
    Entregado el 15 mar 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 15 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    First priority pledge agreement
    Creado el 30 sept 2009
    Entregado el 13 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title and interest in and to the pledged assets being the shares and the related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 13 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 25 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 30 sept 2009
    Entregado el 13 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The present security and the new rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC ("Security Trustee")
    Transacciones
    • 13 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 25 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 29 jul 2009
    Entregado el 04 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 04 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 may 2007
    Entregado el 11 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (In Such Capacity,the 'Security Trustee')
    Transacciones
    • 11 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 may 2003
    Entregado el 28 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at telford road houndmills basingstoke hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 may 2000
    Entregado el 12 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 abr 1999
    Entregado el 28 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 08 oct 1993
    Entregado el 13 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 30 ene 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to be come due from the company to analor john michael design PLC the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    6/9 cynthia street l/b of islington t/n ngl 497668.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga
    • 16 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GAME STORES GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 mar 2012Inicio de la administración
    25 sept 2015Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stuart David Maddison
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Profesional
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0