CASTLE HOME VIDEO LIMITED

CASTLE HOME VIDEO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTLE HOME VIDEO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01938596
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    • Creación artística (90030) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INDEPENDENT VIDEO SERVICES LIMITED28 nov 198528 nov 1985
    SHARPIRON LIMITED13 ago 198513 ago 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2015

    Estado de capital el 06 ene 2015

    • Capital: GBP 101
    SH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Maximilian Dressendoerfer el 17 oct 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Mark David Ranyard el 17 oct 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    8 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 27 ago 2014

    • Capital: GBP 101
    4 páginasSH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England a Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB

    1 páginasAD03

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL England el 10 sept 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Mark David Ranyard como director el 30 abr 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Maximilian Dressendoerfer como director el 30 abr 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de John Leslie Dobinson como director el 30 abr 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Spencer Smith como director el 30 abr 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England el 06 jun 2013

    1 páginasAD01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Timothy Spencer Smith como director el 21 nov 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Abolanle Abioye como secretario el 21 nov 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Adam Martin Barker como director el 21 nov 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Richard James Sharpe como director el 21 nov 2012

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DOBINSON, John Leslie
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Director
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    United KingdomBritish34942720003
    DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Director
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    GermanyGerman157717080010
    RANYARD, Mark David
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Director
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    EnglandBritish154884950002
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Secretario
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    British88802330001
    COOK, Edward John Nicholas
    Flat 2 47 Crooked Billet
    SW19 4RQ London
    Secretario
    Flat 2 47 Crooked Billet
    SW19 4RQ London
    British59798700002
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Secretario
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Secretario
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    O'BRIEN, Judith Elizabeth
    Glinton Cottage Milton Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 8QW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    Glinton Cottage Milton Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 8QW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British53890870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Secretario
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Secretario corporativo
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    BARKER, Adam Martin
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritish162279360001
    BEECHER, Jonathan Roderick
    Great Oaks 7 Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    Director
    Great Oaks 7 Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    British4641390002
    BRYANT, David Thomas
    Ramillies Road
    W4 1JW London
    37
    United Kingdom
    Director
    Ramillies Road
    W4 1JW London
    37
    United Kingdom
    EnglandBritish129141390001
    COKELL, Joseph
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Director
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Gb-EngBritish76396440001
    CONSTANT, Richard Michael
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    Director
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    United KingdomBritish43836310003
    COOK, Edward John Nicholas
    25 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HH London
    Director
    25 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HH London
    British59798700004
    FISHER, Thomas Clive
    1 Nevelle Close
    Binfield
    RG42 4AZ Bracknell
    Berkshire
    Director
    1 Nevelle Close
    Binfield
    RG42 4AZ Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish26978160002
    MUIR, Boyd Johnston
    The Street
    Albury
    GU5 9AX Guildford
    Old Rectory
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Street
    Albury
    GU5 9AX Guildford
    Old Rectory
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish129432950001
    SEMON, Roger
    Kingsfield
    Kings Lane Cobblers Hill
    HP16 9PN Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Kingsfield
    Kings Lane Cobblers Hill
    HP16 9PN Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59798610002
    SHAND, Terence Richard
    Winkins Wood Farm
    Shillinglee Road Plaistow
    RH14 0PQ Billingshurst
    West Sussex
    Director
    Winkins Wood Farm
    Shillinglee Road Plaistow
    RH14 0PQ Billingshurst
    West Sussex
    British4641400002
    SHARPE, David Richard James
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandIrish166109150001
    SMITH, Timothy Spencer
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    Director
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    EnglandBritish130003340001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Director
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritish76655520001

    ¿Tiene CASTLE HOME VIDEO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 07 may 1991
    Entregado el 09 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 09 may 1991Registro de una carga
    • 12 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 22 dic 1988
    Entregado el 11 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ene 1989Registro de una carga
    • 20 jul 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 1987
    Entregado el 28 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb England & Wales PLC
    Transacciones
    • 28 oct 1987Registro de una carga
    Fixed and floating charge
    Creado el 26 jun 1987
    Entregado el 03 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (exceeding those mentioned above) uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 jun 1987
    Entregado el 03 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a flat 7 rippon house, hornchurch essex.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1987Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0