CASTLE HOME VIDEO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CASTLE HOME VIDEO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01938596 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
- Creación artística (90030) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INDEPENDENT VIDEO SERVICES LIMITED | 28 nov 1985 | 28 nov 1985 |
| SHARPIRON LIMITED | 13 ago 1985 | 13 ago 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Maximilian Dressendoerfer el 17 oct 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark David Ranyard el 17 oct 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 27 ago 2014
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England a Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL England el 10 sept 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark David Ranyard como director el 30 abr 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Maximilian Dressendoerfer como director el 30 abr 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de John Leslie Dobinson como director el 30 abr 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Spencer Smith como director el 30 abr 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England el 06 jun 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Timothy Spencer Smith como director el 21 nov 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Abolanle Abioye como secretario el 21 nov 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Martin Barker como director el 21 nov 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Richard James Sharpe como director el 21 nov 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBINSON, John Leslie | Director | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | United Kingdom | British | 34942720003 | |||||
| DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Director | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | Germany | German | 157717080010 | |||||
| RANYARD, Mark David | Director | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | England | British | 154884950002 | |||||
| ABIOYE, Abolanle | Secretario | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| COOK, Edward John Nicholas | Secretario | Flat 2 47 Crooked Billet SW19 4RQ London | British | 59798700002 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Secretario | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| JOY, Matthew Robert | Secretario | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
| O'BRIEN, Judith Elizabeth | Secretario | Glinton Cottage Milton Avenue Chalfont St Peter SL9 8QW Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 53890870001 | ||||||
| STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Secretario | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
| CITY GROUP PLC | Secretario corporativo | 25 City Road EC1Y 1BQ London | 35794270001 | |||||||
| BARKER, Adam Martin | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 162279360001 | |||||
| BEECHER, Jonathan Roderick | Director | Great Oaks 7 Woodway Merrow GU1 2TF Guildford Surrey | British | 4641390002 | ||||||
| BRYANT, David Thomas | Director | Ramillies Road W4 1JW London 37 United Kingdom | England | British | 129141390001 | |||||
| COKELL, Joseph | Director | Talltrees Orpington Road BR7 6RA Chislehurst Kent | Gb-Eng | British | 76396440001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Director | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| COOK, Edward John Nicholas | Director | 25 Ernle Road Wimbledon SW20 0HH London | British | 59798700004 | ||||||
| FISHER, Thomas Clive | Director | 1 Nevelle Close Binfield RG42 4AZ Bracknell Berkshire | England | British | 26978160002 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Director | The Street Albury GU5 9AX Guildford Old Rectory Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 129432950001 | |||||
| SEMON, Roger | Director | Kingsfield Kings Lane Cobblers Hill HP16 9PN Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 59798610002 | |||||
| SHAND, Terence Richard | Director | Winkins Wood Farm Shillinglee Road Plaistow RH14 0PQ Billingshurst West Sussex | British | 4641400002 | ||||||
| SHARPE, David Richard James | Director | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | Irish | 166109150001 | |||||
| SMITH, Timothy Spencer | Director | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | England | British | 130003340001 | |||||
| WALLACE, Paul Frederick | Director | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | 76655520001 |
¿Tiene CASTLE HOME VIDEO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creado el 07 may 1991 Entregado el 09 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 22 dic 1988 Entregado el 11 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 19 oct 1987 Entregado el 28 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 26 jun 1987 Entregado el 03 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (exceeding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 26 jun 1987 Entregado el 03 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a flat 7 rippon house, hornchurch essex. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0