YWC GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaYWC GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01939258
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de YWC GROUP LIMITED?

    • fabricación de otros productos de plástico (22290) / Industrias manufactureras
    • Otras instalaciones de construcción (43290) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra YWC GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YWC GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    YORKSHIRE WINDOW CO. LTD.21 may 198621 may 1986
    FINCHALTON LIMITED15 ago 198515 ago 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de YWC GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para YWC GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    24 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 ene 2020

    24 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 ene 2019

    24 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 ene 2018

    26 páginasLIQ03

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Domicilio social registrado cambiado de Hellaby Industrial Estate Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN a 4th Floor Fountain Precinct Leopold Street Sheffield S1 2JA el 10 feb 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    16 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 19 ene 2017

    LRESEX

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Kevin Taylor como director el 10 jun 2016

    2 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2015

    26 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2015

    Estado de capital el 02 sept 2015

    • Capital: GBP 60,800
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2014

    27 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 oct 2014

    Estado de capital el 07 oct 2014

    • Capital: GBP 60,800
    SH01

    Cese del nombramiento de Steven Roger Cousins como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Steven Roger Cousins como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Steven Roger Cousins como director el 25 jul 2006

    1 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jonathan Bailey como director

    2 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2013

    25 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de YWC GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Secretario
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    British114656960001
    CARTER, Rex Andrew
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    Director
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant82322290002
    CHESTER, Ian Robert
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    Director
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone181466460001
    COUSINS, Steven Roger
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    Director
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector181551540001
    YARLETT, Michael Stewart
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    Director
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    EnglandBritishCompany Director33028840004
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    ADDY, Christopher
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandEnglishChartered Accountant93315810001
    ALLSOPP, Richard Malcolm
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant3241690001
    BAILEY, Jonathan Trevor
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    Director
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone169581220001
    BLAGDEN, John Charles
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    Director
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    BritishProduction Director19379850002
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Director
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector114656960001
    KEENAN, Robert
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCivil Engineer70765950001
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Director designado
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    RIGBY, Edwin John
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    Director
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    United KingdomBritishDirector87672510001
    SCOTT, Paul Graham
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    BritishProduction Development Director19379840001
    SHAW, Anthony
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    Director
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    BritishSales Director19379820003
    TAYLOR, Kevin
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector81151010003
    WILSON, Howard James
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManager46326000001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de YWC GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Michael Stewart Yarlett
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    25 ago 2016
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene YWC GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 may 2013
    Entregado el 07 may 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    A. by way of first legal mortgage the specified real property namely;. 1. unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate, hellaby, rotherham, south yorkshire as the same is contained in SYK253742. 2. land on the south west side of braithwell way, hellaby industrial estate yorkshire as the same is contained in SYK365435. 3. land on the south west side of bramley way, hellaby industrial estate, hellaby yorkshire as the same is contained in SYK365434. B. by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 4.1(a));. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. C. by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 3 of schedule 1;. D. by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 4.1(n);. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Centric SPV1 Limited
    Transacciones
    • 07 may 2013Registro de una carga (MR01)
    Legal charge
    Creado el 20 abr 2012
    Entregado el 27 abr 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises at bramley way hellaby rotherham t/no SYK253742 SYK365435 SYK365434.
    Personas con derecho
    • Michael Stewart Yarlett
    Transacciones
    • 27 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    Deposit agreement
    Creado el 24 abr 2006
    Entregado el 27 abr 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £3,231.25 and the monies held in the account.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Window Company Limited
    Transacciones
    • 27 abr 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 10 dic 2003
    Entregado el 12 dic 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2003Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 10 dic 2003
    Entregado el 12 dic 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate hellaby t/n SYK253742. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 25 jun 1997
    Entregado el 05 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a unit bt 512/3 a-f hellaby industrial estate hellaby rotherham south yorkshire t/no;-SYK253742 together with goodwill of any business at the property and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 feb 1988
    Entregado el 24 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property situate and k/a factory unit no: bt 51213 on the hellaby industrial estate rotherham south yorkshire.
    Personas con derecho
    • The English Industrial Estates Corporation
    Transacciones
    • 24 feb 1988Registro de una carga
    • 01 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 abr 1986
    Entregado el 08 may 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 may 1986Registro de una carga
    • 25 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene YWC GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 ene 2017Inicio de la liquidación
    24 jun 2021Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Adrian Graham
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    Profesional
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0