TRANSCOMM PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRANSCOMM PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 01942212
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRANSCOMM PLC?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra TRANSCOMM PLC?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRANSCOMM PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TARDIS TRANSCOMMUNICATIONS PLC13 dic 199913 dic 1999
    SCOTSWOOD INDUSTRIES PLC21 sept 199521 sept 1995
    BISCAY INVESTMENTS PLC02 nov 199202 nov 1992
    LAZADEAL PUBLIC LIMITED COMPANY 08 jun 198908 jun 1989
    PERMA INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY12 ago 198712 ago 1987
    LAZADEAL PUBLIC LIMITED COMPANY 27 ago 198527 ago 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRANSCOMM PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRANSCOMM PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cambio de datos del director Timothy James Beresford Shaw el 24 nov 2011

    2 páginasCH01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 81 Newgate Street London EC1A 7AJ el 18 abr 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 mar 2011

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Adam Baird como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jul 2010

    Estado de capital el 08 jul 2010

    • Capital: GBP 5,261,021.7
    SH01

    Cambio de datos del director Roger Vigilance el 26 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Timothy James Beresford Shaw el 26 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Adam John Baird el 26 oct 2009

    2 páginasCH01

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    14 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de TRANSCOMM PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Secretario corporativo
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    45816950001
    SHAW, Timothy James Beresford
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    Director
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor104815050001
    VIGILANCE, Roger Orin
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritishCorporate Development Director112894720001
    BACKHOUSE, Russell John
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Acc37568000006
    BALME, Anthony David Nettleon
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    Secretario
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    British155915350002
    BUCKMASTER, Douglas Graham
    The Flat Lindisfarne Elms Avenue
    Parkstone
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Secretario
    The Flat Lindisfarne Elms Avenue
    Parkstone
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British13913790001
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Secretario
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    British1227500001
    PRIOR, Stephen John
    16a Haygarth Place
    High Street Wimbledon
    SW19 5BX London
    Secretario
    16a Haygarth Place
    High Street Wimbledon
    SW19 5BX London
    BritishChartered Secretary1167820004
    BACKHOUSE, Russell John
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    Director
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Acc37568000006
    BAIRD, Adam John
    81 Newgate Street
    London
    EC1A 7AJ
    Director
    81 Newgate Street
    London
    EC1A 7AJ
    United KingdomBritishAccountant133855430001
    BALME, Anthony David Nettleon
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    Director
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishWool Broker155915350002
    BOWEN, David
    59 Farm Road
    Winchmore Hill
    N21 3JD London
    Director
    59 Farm Road
    Winchmore Hill
    N21 3JD London
    BritishAccountant106789240001
    BROCKLEBANK, Aubrey Thomas, Sir
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Gb-GbnBritishCompany Director56733000005
    CAMILLERI, John Michael
    55 Hihglands
    Whiteparish
    SP5 2SX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    55 Hihglands
    Whiteparish
    SP5 2SX Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector35185850001
    COLLIER, David
    12 Coniston Road
    Blackrod
    BL6 5DN Bolton
    Lancashire
    Director
    12 Coniston Road
    Blackrod
    BL6 5DN Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director20891600001
    COPPIN, Raymond
    9 Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6NU Maidenhead
    Berkshire
    Director
    9 Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6NU Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant93818410001
    DOYLE, Raymond
    6 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    Director
    6 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director35730720001
    FITTON, Andrew Charles
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    Director
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director7527160002
    FORMBY, Paul Madders
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    Director
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    BritishBusiness Consultant87104890001
    FOX, John
    270 Singlewell Road
    DA11 7RE Gravesend
    Kent
    Director
    270 Singlewell Road
    DA11 7RE Gravesend
    Kent
    EnglandBritishTax Manager76187760001
    FURMSTON, Jonathan Mark
    St. Leonards Park House
    RH13 6EG Horsham
    4
    Sussex
    Director
    St. Leonards Park House
    RH13 6EG Horsham
    4
    Sussex
    United KingdomBritishBt Executive136631740001
    HAYNES, Vivienne Ann
    24 North Hill
    Highgate
    N6 4QA London
    Director
    24 North Hill
    Highgate
    N6 4QA London
    EnglandBritishSolicitor54182100002
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Director
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritishEngineer1227500001
    HUGHES, David Edward
    107 Henley Road
    IP1 4NG Ipswich
    Director
    107 Henley Road
    IP1 4NG Ipswich
    EnglandBritishEngineer111355350001
    HUNT, Ashton Willis
    2 West Hayes
    Hatfield Heath
    CM22 7DH Bishop's Stortford
    Herts
    Director
    2 West Hayes
    Hatfield Heath
    CM22 7DH Bishop's Stortford
    Herts
    BritishAccountant88138590001
    JARVIS, John Edwin
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    Director
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director62045640001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishChairman74872510003
    MCNULTY, Kevin
    4 Highworth
    Compton Lane
    RH13 5PU Horsham
    West Sussex
    Director
    4 Highworth
    Compton Lane
    RH13 5PU Horsham
    West Sussex
    BritishBt Executive98350030001
    MODI, Rajul Kishore
    2 Wildcroft Gardens
    Canons Park
    HA8 6TJ Edgware
    Middlesex
    Director
    2 Wildcroft Gardens
    Canons Park
    HA8 6TJ Edgware
    Middlesex
    BritishBt Executive98350020001
    MONKCOM, Stephen Roderick
    6 Carnoustie Grove
    Bletchley
    MK3 7RP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    6 Carnoustie Grove
    Bletchley
    MK3 7RP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector9918790001
    NICOLLE, Adrian Christopher
    Vyne Lodge
    Easton Common Hill, Winterslow
    SP5 1QD Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Vyne Lodge
    Easton Common Hill, Winterslow
    SP5 1QD Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector112555010001
    PATEL, Chetan Kumar
    4 Airedale Road
    Ealing
    W5 4SD London
    Director
    4 Airedale Road
    Ealing
    W5 4SD London
    BritishBusiness Manager108844090001
    PULLIN, Richard Anthony
    Bendysh Hall Barn
    Radwinter
    CB10 2UA Saffron Walden
    Essex
    Director
    Bendysh Hall Barn
    Radwinter
    CB10 2UA Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director103638490001
    REDMOND, Peter
    54 St Albans Crescent
    N22 5NB London
    Director
    54 St Albans Crescent
    N22 5NB London
    BritishCorporate Consultancy37127970001
    SHEARD, Matthew David George
    Flat 2
    73 Munster Road
    SW6 5RE London
    Director
    Flat 2
    73 Munster Road
    SW6 5RE London
    United KingdomBritishAccountant111321360001

    ¿Tiene TRANSCOMM PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 28 abr 2003
    Entregado el 03 may 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 03 may 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2001
    Entregado el 12 oct 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Factors Limited
    Transacciones
    • 12 oct 2001Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 29 sept 1995
    Entregado el 17 oct 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 1995Registro de un cargo (395)
    Fixed and floating charge
    Creado el 19 sept 1990
    Entregado el 25 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1990Registro de una carga
    • 24 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 12 nov 1987
    Entregado el 28 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb England of Wales PLC
    Transacciones
    • 28 nov 1987Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 21 mar 1986
    Entregado el 02 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 02 abr 1986Registro de una carga

    ¿Tiene TRANSCOMM PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 ene 2012Fecha de disolución
    30 mar 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0