CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01949119
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    • Seguros de vida (65110) / Actividades financieras y de seguros
    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WELLINGTON UNDERWRITING HOLDINGS LIMITED20 sept 198520 sept 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginasLIQ13

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG el 29 jun 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 22 jun 2022

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Christopher John Read como director el 05 feb 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Richard Bradbrook como director el 05 feb 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Craig Standen como director el 17 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Juliet Phillips como director el 17 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    13 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Andrew Jardine como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Juliet Phillips como director el 26 sept 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Clynton Jacobus Luttig como director el 26 sept 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secretario
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201004350001
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    READ, Christopher John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish267508980001
    STANDEN, Craig
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish265497100001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secretario
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Secretario
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    160260190001
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Secretario
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    CATLIN (WELLINGTON) INSURANCE LIMITED
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01321649
    100566440004
    AGNEW, Ian Charles
    9 Albert Place
    W8 London
    Director
    9 Albert Place
    W8 London
    British6418620002
    ALEXANDER, John Lindsay, Sir
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    Director
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    British6418630001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Director
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Director
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrish240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Director
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    COOPER, Anthony Geoffrey
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    Director
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    British73654090001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Director
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Director
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    FRESHWATER, Neil Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Director
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    British9580170001
    IBESON, David Christopher Ben
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish52745170002
    JARDINE, Paul Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish62337170003
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Director
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    United KingdomBritish54716770009
    MAYO, John William
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Director
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    British8271050001
    NORRIE, Guy Bainbridge, The Honourable
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    British6420160001
    O'BRIEN, Christopher Patrick James
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    Director
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    British78831780002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Director
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    PETZOLD, Martin William
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    Director
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    British12148870001
    PHILLIPS, Juliet
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish211555110001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Director
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritish137567870001
    PRENTICE, John Oscar
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Director
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    British8271070001
    PRIMER, Daniel Francis
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomAmerican112177980002
    SINFIELD, Nicholas Christopher
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Director
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish165481720002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5562639
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 11 dic 2003
    Entregado el 22 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 27 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 28 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 jul 1997
    Entregado el 29 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 nov 1992
    Entregado el 21 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 ago 1988
    Entregado el 18 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 ago 1988Registro de una carga
    • 08 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 ago 1988
    Entregado el 18 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 1988Registro de una carga
    • 02 mar 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 dic 1985
    Entregado el 13 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See doc M10 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1986Registro de una carga
    Charge
    Creado el 30 dic 1985
    Entregado el 06 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Borrower's interest in the l/h properties etc and/or the proceeds of salethereof. Specific charge over all other securities etc the goodwill & uncalled capital etc floating charge undertaking and all property and assets present and future (see doc M9 for full details).
    Personas con derecho
    • Baring Brothers & Co Limited
    Transacciones
    • 06 ene 1986Registro de una carga

    ¿Tiene CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 jun 2022Inicio de la liquidación
    02 jun 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Profesional
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0