J & N WADE LIMITED.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJ & N WADE LIMITED.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01957925
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de J & N WADE LIMITED.?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra J & N WADE LIMITED.?

    Dirección de la sede social
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de J & N WADE LIMITED.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BAILCROFT LIMITED12 nov 198512 nov 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de J & N WADE LIMITED.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para J & N WADE LIMITED.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ England a C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH el 15 mar 2022

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 feb 2022

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Marcus Leek como director el 01 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Christopher James Hogan como director el 01 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Segunda presentación para el nombramiento de Toby Train como director

    6 páginasRP04AP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 08 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 5th Floor Maple House Mutton Lane Potters Bar Hertfordshire EN6 5BS a Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ el 11 may 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de J & N WADE LIMITED.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEEK, Marcus
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish236640560001
    TRAIN, Toby
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    United KingdomBritish124023220002
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Secretario
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    British9549440001
    ATKINS, David Edward
    22 Marshwood Road
    GU18 5QZ Lightwater
    Surrey
    Secretario
    22 Marshwood Road
    GU18 5QZ Lightwater
    Surrey
    British2809620002
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Secretario
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    Secretario
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    AMOS, Michael Charles Gilbert
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    Director
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    British9904110001
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Director
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    British9549440001
    BURR, Anthony Hugh
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Director
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    British986020002
    CHARMAN, Kenneth
    21 Old Bridge Close
    Bursledon
    SO31 8AX Southampton
    Hampshire
    Director
    21 Old Bridge Close
    Bursledon
    SO31 8AX Southampton
    Hampshire
    British14909700001
    CROXSON, Neil Michael
    Floor
    Maple House Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Floor
    Maple House Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    UkBritish96469690006
    DELANY, Martin
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    Director
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    Irish44130110002
    FITCHETT, David John
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom83165530001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Director
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish97001960001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Irish70451130001
    HAMMERSCHMID, Thomas
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Director
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Austrian114541610001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Director
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish62962370002
    HOGAN, John Christopher James
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomIrish197357940001
    HOGG, David Ribton
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    Director
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    British2809630001
    HUNTER, Andrew James Woosnam
    11 Riverholme
    Hampton Court
    KT8 9BP East Molesey
    Surrey
    Director
    11 Riverholme
    Hampton Court
    KT8 9BP East Molesey
    Surrey
    British14909690001
    JORDAN, Alan
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    Director
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    Irish73934080001
    LASCHKAR, Henri-Paul
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Herts
    Director
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Herts
    UkFrench139160640005
    LAYCOCK, Derek Francis
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    Director
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    British78294880001
    LILLIS, James Anthony
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Director
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Irish49070590001
    MOLLOY, Brian Patrick
    Columbine Lodge
    Cornelscourt
    IRISH Dublin 18
    Eire
    Director
    Columbine Lodge
    Cornelscourt
    IRISH Dublin 18
    Eire
    IrelandIrish49573400001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    Director
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish177829370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Director
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    ROFF, Alan
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    Director
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    EnglandBritish205772150001
    ROSE, Richard Sidney
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Director
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    EnglandBritish20113670001
    WESTMAN, Lawrence
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    Director
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    IrelandIrish241846320001
    WOUTERSE, Alexander Jan
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Director
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Dutch105846620001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de J & N WADE LIMITED.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wf Electrical Limited
    Hatchford Way
    Sheldon
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    30 jun 2016
    Hatchford Way
    Sheldon
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk Company Register
    Número de registro00085004
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene J & N WADE LIMITED. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Confirmatory charge
    Creado el 10 feb 1986
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 ene 1986
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 17 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing form time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 feb 1986Registro de una carga
    • 04 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properies floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental cahrge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing form time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 02 ago 1983
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed cahrge over all book and other debts.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 04 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/a and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties flaoting charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h and l/a properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creado el 10 feb 1981
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 15 ago 1979
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 feb 1977
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 feb 1974
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 mar 1972
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 dic 1970
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General charge
    Creado el 25 jun 1969
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General charge
    Creado el 19 dic 1966
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General charge
    Creado el 31 dic 1965
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the undertaking (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General charge
    Creado el 10 ene 1964
    Adquirido el 31 ene 1986
    Entregado el 21 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies owing from time to time
    Breve descripción
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1986Registro de una carga
    • 23 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene J & N WADE LIMITED. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 jun 2023Fecha prevista de disolución
    24 feb 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stacey Brown
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Profesional
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0