SYSTEMS TEAM LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSYSTEMS TEAM LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01959626
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SYSTEMS TEAM LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SYSTEMS TEAM BRISTOL LIMITED02 sept 199702 sept 1997
    MX BUSINESS SYSTEMS PLC06 sept 199606 sept 1996
    SYSTEMS TEAM PLUSMARK LIMITED30 sept 199230 sept 1992
    SYSTEMS TEAM DEVELOPMENT LIMITED05 feb 198605 feb 1986
    BELLKNOCK LIMITED15 nov 198515 nov 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    GAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 08 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 sept 2013

    Estado de capital el 04 sept 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    6 páginasAA

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Denise Williams como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Preedy como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario

    2 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director

    3 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013

    2 páginasAD01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 08 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Richard Ian Preedy como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ms Kerry Jane Crompton el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* el 14 may 2012

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de SYSTEMS TEAM LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952900001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    BLACK, Samuel Colin
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    British2814270004
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    BLACK, Samuel Colin
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Director
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish2814270004
    CAINES, John Michael
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish26293160002
    CAMPIN, Richard Michael
    Philbies
    Hardings Green, Cookham
    SL6 9NX Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Philbies
    Hardings Green, Cookham
    SL6 9NX Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish143673940001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    EVERSHED, Richard Albury
    49 Belle Vue Crescent
    Clifton
    BS8 4TF Bristol
    Director
    49 Belle Vue Crescent
    Clifton
    BS8 4TF Bristol
    British64769170001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Director
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    FOWLER, Simon Richard
    Laburnum Cottage
    The Village
    GL18 2AJ Dymock
    Gloucestershire
    Director
    Laburnum Cottage
    The Village
    GL18 2AJ Dymock
    Gloucestershire
    British77101900002
    ILES, Geoffrey
    Cider House
    Chewton Keynsham Keynsham
    BS31 2SS Bristol
    Avon
    Director
    Cider House
    Chewton Keynsham Keynsham
    BS31 2SS Bristol
    Avon
    United KingdomBritish2814280004
    ILES, Geoffrey
    21 West Town Park
    Brislington
    BS4 5EA Bristol
    Avon
    Director
    21 West Town Park
    Brislington
    BS4 5EA Bristol
    Avon
    British2814280001
    KROEGER, Peter
    3 Park Corner
    SL6 6PF Maidenhead
    Berkshire
    Director
    3 Park Corner
    SL6 6PF Maidenhead
    Berkshire
    British30322950001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    LINTON, David Gibson
    The School House The Street
    Coaley
    GL11 5EB Dursley
    Gloucestershire
    Director
    The School House The Street
    Coaley
    GL11 5EB Dursley
    Gloucestershire
    British52233990001
    LLOYD, Leslie Raymond
    1 Downesway
    SK9 7XB Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    1 Downesway
    SK9 7XB Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritish2814290001
    MOORE, Richard John
    Dunelin
    2 Lee Avenue
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Dunelin
    2 Lee Avenue
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    British30322940001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Director
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Director
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Director
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330003
    WHITFIELD, David
    Mortons St Johns Square
    GL14 3EX Cinderford
    Gloucestershire
    Director
    Mortons St Johns Square
    GL14 3EX Cinderford
    Gloucestershire
    EnglandBritish44467350001
    WILLIAMS, Robert Charles
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    Director
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    British68017980001

    ¿Tiene SYSTEMS TEAM LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 oct 2007
    Entregado el 15 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transacciones
    • 15 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 may 1999
    Entregado el 03 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 ago 1993
    Entregado el 13 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 abr 1986
    Entregado el 21 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1986Registro de una carga
    • 03 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 14 mar 1986
    Entregado el 17 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the systems team group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC.
    Transacciones
    • 17 mar 1986Registro de una carga

    ¿Tiene SYSTEMS TEAM LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2014Inicio de la liquidación
    05 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0