ASHBOURNE LEASING LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ASHBOURNE LEASING LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01964687 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ASHBOURNE LEASING LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ASHBOURNE LEASING LIMITED?
Dirección de la sede social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASHBOURNE LEASING LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
MANOR NURSING HOMES LIMITED | 25 nov 1985 | 25 nov 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHBOURNE LEASING LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHBOURNE LEASING LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 24 jul 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Midmer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kamma Foulkes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director William James Buchan el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Richard Neil Midmer el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Kamma Foulkes el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario William David Mcleish el 27 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ASHBOURNE LEASING LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
COPELAND, Robert Nigel | Secretario | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | British | Finance Director | 5690880001 | |||||
FEENEY, Martin | Secretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | |||||
FORD, Colin Andrew | Secretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
HURRELL, Steven Alfred | Secretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
KIME, Sean Thomas | Secretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
MACFARLANE, Rona Jane | Secretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304800001 | |||||||
MCLEISH, William David | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
MURPHY, Charles Furber | Secretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
MURRAY, Karen Mary | Secretario | Willerton Trumpsgreen Road GU25 4HH Virginia Water Surrey | British | 27248850001 | ||||||
RUTTER, Christopher | Secretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
ABLETT, Julie | Director | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | Company Director | 57906600001 | |||||
BARLOW, George Edward | Director | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 66559170001 | ||||
BOLOT, Timothy James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BRADEEN, Chester Howard | Director | Barberry Cottage Cheapside Road SL5 7QR Ascot Berkshire | Us Citizen | Health Care Admistrator | 44958580001 | |||||
BUCHAN, William James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Director | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
COPELAND, Robert Nigel | Director | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 5690880001 | ||||
FARRALL, Elaine Ann | Director | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | Director | 14241020001 | |||||
FEENEY, Martin | Director | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | ||||
FLAHERTY, James Paul | Director | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | Director | 100530310001 | |||||
FOULKES, Kamma | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
GOSLING, Mark David | Director | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | Director | 66801660002 | |||||
HAMILTON, Thomas Banks | Director | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | Company Chairman | 79846610001 | |||||
JAP, Chee Miau | Director | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | Director | 101200680001 | ||||
LAWRENCE, Stephen John | Director | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | Director | 5579020001 | ||||
LOCK, Jason David | Director | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MARK, Larry Edward | Director | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | Company Director | 5076900001 | |||||
MCINTEER, Warren Hill | Director | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Director | 100131200001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MORETON, John Ernest | Director | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | Company Director | 80392940001 | |||||
MOSS, John Rhys | Director | Bryn Y Gwynt Graigfechan LL15 2EY Ruthin Clwyd | British | Company Director | 36148600001 | |||||
MURPHY, Charles Furber | Director | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | Chartered Accountant | 69603410001 | |||||
MURPHY, John | Director | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 |
¿Tiene ASHBOURNE LEASING LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 13 mar 1995 Entregado el 16 mar 1995 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a land adjoining new hall farm chester high road gayton t/n ms 273427 together with all buildings and fixtures .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Single debenture | Creado el 02 nov 1992 Entregado el 13 nov 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 06 dic 1990 Entregado el 13 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from exceler health care limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción All that f/hold property k/as new hall manor chester high road neston cheshire. Title no. Ms 233145 together with all buildings and fixtures thereon assignment of the goodwill of the business carried on at the property the full benefit of all present and future licences in connection with the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 20 dic 1985 Entregado el 02 ene 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción New hall grayton wirral merseyside. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0