CAPE CONTRACTS LIMITED

CAPE CONTRACTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAPE CONTRACTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01968580
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAPE CONTRACTS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CAPE CONTRACTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Drayton Hall Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    England
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPE CONTRACTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASPECTADD LIMITED16 ene 200216 ene 2002
    CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED05 ago 199705 ago 1997
    JOSEPH NADIN HOLDINGS LIMITED21 may 199321 may 1993
    CAPE VITRATECH LIMITED27 oct 198727 oct 1987
    T.S.C.VITRATECH LIMITED19 sept 198619 sept 1986
    ATLASGEM LIMITED04 dic 198504 dic 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPE CONTRACTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPE CONTRACTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB el 14 mar 2013

    1 páginasAD01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom el 04 oct 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 sept 2012

    LRESSP

    Nombramiento de Christopher Francis Judd como secretario el 23 may 2012

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jeremy Philip Gorman como secretario el 23 may 2012

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 feb 2012

    Estado de capital el 28 feb 2012

    • Capital: GBP 120,480
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lucy Turner como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Jeremy Philip Gorman como secretario

    1 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Rachel Nancye Carr el 01 dic 2010

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL el 01 dic 2010

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del secretario Lucy Finch Turner el 23 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mrs Victoria Anne George el 18 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Rachel Nancye Carr el 18 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de CAPE CONTRACTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    Secretario
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    169524500001
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish133976650005
    GEORGE, Victoria Anne
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish134024500001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    British82905830001
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675700001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Secretario
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Secretario
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Secretario
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    British99402260002
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Director
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    British131046090001
    BOWDLER, Timothy John
    Heathcliff
    1 Constable Road
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Heathcliff
    1 Constable Road
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    British33861570001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Director
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    British40873830002
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    British82905830001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish89560440001
    GRATTON, Gordon Cameron Paul
    1 Beckside Gardens
    LS16 5QZ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    1 Beckside Gardens
    LS16 5QZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish121813940001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish829660002
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Director
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Director
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritish99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    ¿Tiene CAPE CONTRACTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 20 jul 2001
    Entregado el 26 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Breve descripción
    Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transacciones
    • 26 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third supplemental trust deed
    Creado el 07 jun 1988
    Entregado el 10 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,458, 818 7.1/4 percent unsecured lon stock 1986/91 and all other moneys due & to become due supplemental to a trust deed dated 27/6/67 and deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1988Registro de una carga
    • 19 jul 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 08 jun 1987
    Entregado el 10 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1987Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 27 abr 1987
    Entregado el 27 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 27 abr 1987Registro de una carga

    ¿Tiene CAPE CONTRACTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 may 2013Fecha de disolución
    14 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0