T.W. TELECOM LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | T.W. TELECOM LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01971198 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de T.W. TELECOM LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra T.W. TELECOM LIMITED?
Dirección de la sede social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T.W. TELECOM LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
TWO-WAY RADIO SERVICE LIMITED | 13 dic 1985 | 13 dic 1985 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de T.W. TELECOM LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para T.W. TELECOM LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Notification de Project Telecom Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 207 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 26 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Nigel Evans como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Purkess como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como secretario | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Garth Wright como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Diane Mcintyre como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de T.W. TELECOM LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
EVANS, David Nigel | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 134975040001 | ||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
CLARKE, Gael | Secretario | Woodview Horncastle Road Southrey Wood LN3 5SU Lincoln Lincolnshire | British | Chairman | 60673720001 | |||||||||
DEARDEN, Anthony Vincent | Secretario | Eastbury House Penn Lane LE14 4JA Stathern Leicestershire | British | 147413990001 | ||||||||||
HARGREAVES, Geoffrey Peter | Secretario | 16 Erica Avenue OL4 2TS Oldham Lancashire | British | 12138950001 | ||||||||||
HOWIE, Philip Robert Sutherland | Secretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
WRIGHT, Garth Howard | Secretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 111162790001 | ||||||||||
ALLEN, Christian Philip Quentin | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 123612980001 | |||||||||
BROCKLEHURST, Nigel | Director | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | Director | 83126790001 | |||||||||
CHESWORTH, Paul | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 99525280001 | |||||||||
CUNNINGHAM, Richard Hugh | Director | Ham House 17 Cottesmore Road Ashwell LE15 9RU Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 43180900004 | ||||||||
EDWARD, Duncan James | Director | 118 Tadcaster Road Dringhouse YO24 1LU York | British | Sales Manager | 73522700001 | |||||||||
EVANS, Mark | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||||||
FINCH, Joanne Sarah | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||||||
HARGREAVES, Geoffrey Peter | Director | 16 Erica Avenue OL4 2TS Oldham Lancashire | British | Radio Technician | 12138950001 | |||||||||
HOLROYD, Michael Anthony | Director | Tower View Pleasington Lane Pleasington BB2 5JH Blackburn Lancashire | England | British | Marketing | 31418500001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
LISTON, Edward John | Director | 5 White Road New Mills SK22 4EL High Peak Derbyshire | British | Company Director | 82360070001 | |||||||||
MCGEORGE, Kenneth Roy | Director | Ley Farm EX22 7NY Milton Damerel Devon | England | British | Co Dir | 61230560002 | ||||||||
NOWAK, Thomas, Dr | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | Director | 174443800001 | ||||||||
PURKESS, Martin John | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | Director | 139360020001 | ||||||||
RADFORD, Timothy Piers | Director | Heydour House Heydour NG32 3NG Grantham Lincolnshire | England | British | Managing Director | 26144060004 | ||||||||
READ, Nicholas Jonathan | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Co Dir | 87149560001 | ||||||||
SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance Technology & Support | 158146600001 | ||||||||
SHARP, Philippa Mary | Director | 35 Venice Court Samuel Ogden Street M1 7AX Manchester | British | Director | 50878040001 | |||||||||
SHARP, Philippa Mary | Director | 35 Venice Court Samuel Ogden Street M1 7AX Manchester | British | Director | 50878040001 | |||||||||
SMITH, Christopher Peter | Director | 73 Merchant Quay Salford Quays M50 3XQ Manchester | British | Director | 8208160001 | |||||||||
SMITH, Christopher Peter | Director | 73 Merchant Quay Salford Quays M50 3XQ Manchester | British | Director | 8208160001 | |||||||||
THOMPSON, Harold John | Director | 24 Springmeadow Charlesworth SK13 5ES Glossop Derbyshire | England | British | Radio Technician | 1474970002 | ||||||||
THOMPSON, Sharon Elizabeth | Director | 21 Highfield Road Mellor SK6 5AL Stockport Cheshire | British | Secretary | 1474960001 | |||||||||
TOURNON, Emanuele | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | Director | 103542080002 | ||||||||
TOWNSEND, John Raymond | Director | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | Director | 95223480001 | |||||||||
WEBB, Denys William | Director | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | Director | 76074580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de T.W. TELECOM LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project Telecom Holdings Limited | 06 abr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene T.W. TELECOM LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Creado el 15 dic 2000 Entregado el 19 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a service provider agreement dated 15TH december 2000 | |
Breve descripción First fixed charge all intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arisimng under the service provider agreement (the "subscriber base") and any other rights benefits or interests now and in future comprised in the subscriber base together with first fixed charge all book debts arising out of the subscriber base and any amount standing to the credit of the company from time to time in the designated account (as defined in the deed of charge) floating charge over the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge | Creado el 12 jul 1996 Entregado el 01 ago 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the service provider agreement dated 11TH july 1996 | |
Breve descripción (I) first fixed charge all intellectual property and goodwill of the company present and future (ii) first fixed charge all book debts and other debts owing to the company (iii) first floating charge all intellectual property goodwill book debts other debts and rights etc. comprised in the subscriber base.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 24 ago 1994 Entregado el 06 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 22 jul 1994 Entregado el 09 ago 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a charter house, latham close, bredbury industrial estate,stockport, cheshire t/no: GM280284 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 16 jun 1986 Entregado el 25 jun 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0