T.W. TELECOM LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaT.W. TELECOM LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01971198
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de T.W. TELECOM LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra T.W. TELECOM LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T.W. TELECOM LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TWO-WAY RADIO SERVICE LIMITED13 dic 198513 dic 1985

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de T.W. TELECOM LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para T.W. TELECOM LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    6 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Notification de Project Telecom Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2016

    7 páginasAA

    legacy

    207 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jun 2016

    Estado de capital el 28 jun 2016

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jun 2015

    Estado de capital el 08 jun 2015

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 26 sept 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 may 2014

    Estado de capital el 22 may 2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr David Nigel Evans como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin Purkess como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Garth Wright como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Diane Mcintyre como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de T.W. TELECOM LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    CLARKE, Gael
    Woodview Horncastle Road
    Southrey Wood
    LN3 5SU Lincoln
    Lincolnshire
    Secretario
    Woodview Horncastle Road
    Southrey Wood
    LN3 5SU Lincoln
    Lincolnshire
    BritishChairman60673720001
    DEARDEN, Anthony Vincent
    Eastbury House
    Penn Lane
    LE14 4JA Stathern
    Leicestershire
    Secretario
    Eastbury House
    Penn Lane
    LE14 4JA Stathern
    Leicestershire
    British147413990001
    HARGREAVES, Geoffrey Peter
    16 Erica Avenue
    OL4 2TS Oldham
    Lancashire
    Secretario
    16 Erica Avenue
    OL4 2TS Oldham
    Lancashire
    British12138950001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    WRIGHT, Garth Howard
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British111162790001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    CUNNINGHAM, Richard Hugh
    Ham House 17 Cottesmore Road
    Ashwell
    LE15 9RU Oakham
    Leicestershire
    Director
    Ham House 17 Cottesmore Road
    Ashwell
    LE15 9RU Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritishManaging Director43180900004
    EDWARD, Duncan James
    118 Tadcaster Road
    Dringhouse
    YO24 1LU York
    Director
    118 Tadcaster Road
    Dringhouse
    YO24 1LU York
    BritishSales Manager73522700001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    HARGREAVES, Geoffrey Peter
    16 Erica Avenue
    OL4 2TS Oldham
    Lancashire
    Director
    16 Erica Avenue
    OL4 2TS Oldham
    Lancashire
    BritishRadio Technician12138950001
    HOLROYD, Michael Anthony
    Tower View Pleasington Lane
    Pleasington
    BB2 5JH Blackburn
    Lancashire
    Director
    Tower View Pleasington Lane
    Pleasington
    BB2 5JH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishMarketing31418500001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LISTON, Edward John
    5 White Road
    New Mills
    SK22 4EL High Peak
    Derbyshire
    Director
    5 White Road
    New Mills
    SK22 4EL High Peak
    Derbyshire
    BritishCompany Director82360070001
    MCGEORGE, Kenneth Roy
    Ley Farm
    EX22 7NY Milton Damerel
    Devon
    Director
    Ley Farm
    EX22 7NY Milton Damerel
    Devon
    EnglandBritishCo Dir61230560002
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    RADFORD, Timothy Piers
    Heydour House Heydour
    NG32 3NG Grantham
    Lincolnshire
    Director
    Heydour House Heydour
    NG32 3NG Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritishManaging Director26144060004
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCo Dir87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support158146600001
    SHARP, Philippa Mary
    35 Venice Court
    Samuel Ogden Street
    M1 7AX Manchester
    Director
    35 Venice Court
    Samuel Ogden Street
    M1 7AX Manchester
    BritishDirector50878040001
    SHARP, Philippa Mary
    35 Venice Court
    Samuel Ogden Street
    M1 7AX Manchester
    Director
    35 Venice Court
    Samuel Ogden Street
    M1 7AX Manchester
    BritishDirector50878040001
    SMITH, Christopher Peter
    73 Merchant Quay
    Salford Quays
    M50 3XQ Manchester
    Director
    73 Merchant Quay
    Salford Quays
    M50 3XQ Manchester
    BritishDirector8208160001
    SMITH, Christopher Peter
    73 Merchant Quay
    Salford Quays
    M50 3XQ Manchester
    Director
    73 Merchant Quay
    Salford Quays
    M50 3XQ Manchester
    BritishDirector8208160001
    THOMPSON, Harold John
    24 Springmeadow
    Charlesworth
    SK13 5ES Glossop
    Derbyshire
    Director
    24 Springmeadow
    Charlesworth
    SK13 5ES Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishRadio Technician1474970002
    THOMPSON, Sharon Elizabeth
    21 Highfield Road
    Mellor
    SK6 5AL Stockport
    Cheshire
    Director
    21 Highfield Road
    Mellor
    SK6 5AL Stockport
    Cheshire
    BritishSecretary1474960001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Director
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    BritishDirector95223480001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Director
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector76074580001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de T.W. TELECOM LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3891879
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene T.W. TELECOM LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 15 dic 2000
    Entregado el 19 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a service provider agreement dated 15TH december 2000
    Breve descripción
    First fixed charge all intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arisimng under the service provider agreement (the "subscriber base") and any other rights benefits or interests now and in future comprised in the subscriber base together with first fixed charge all book debts arising out of the subscriber base and any amount standing to the credit of the company from time to time in the designated account (as defined in the deed of charge) floating charge over the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bt Cellnet
    Transacciones
    • 19 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 12 jul 1996
    Entregado el 01 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the service provider agreement dated 11TH july 1996
    Breve descripción
    (I) first fixed charge all intellectual property and goodwill of the company present and future (ii) first fixed charge all book debts and other debts owing to the company (iii) first floating charge all intellectual property goodwill book debts other debts and rights etc. comprised in the subscriber base.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 01 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 24 ago 1994
    Entregado el 06 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 22 jul 1994
    Entregado el 09 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a charter house, latham close, bredbury industrial estate,stockport, cheshire t/no: GM280284 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 16 jun 1986
    Entregado el 25 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 jun 1986Registro de una carga
    • 21 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0